GLOBIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBIX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03616569
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLOBIX LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GLOBIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBIX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLOBIX LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 gen 2016

    2 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Masters House 107 Hammersmith Road London W14 0QH a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 12 mag 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 apr 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di David Crowther come amministratore in data 14 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Wilhelmus Theresia Jozef Hageman come amministratore in data 14 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Tobin come amministratore in data 24 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2014

    Stato del capitale al 14 ago 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Brian David Mcarthur-Muscroft come amministratore in data 31 gen 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Coupland il 29 giu 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Brian David Mcarthur-Muscroft il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Tobin il 19 lug 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di GLOBIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUNTER, Anthony George
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    British66859190003
    COUPLAND, Robert Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish138313750002
    CROWTHER, David
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish184391050001
    HAGEMAN, Wilhelmus Theresia Jozef
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    NetherlandsDutch190923150001
    KIRK, Colin
    10 Spratt Hall Road
    Wanstead
    E11 2RQ London
    Segretario
    10 Spratt Hall Road
    Wanstead
    E11 2RQ London
    British85982990001
    SHARIF, Raja
    198 Grove Hall Court
    Hall Road St Johns Wood
    NW8 9NX London
    Segretario
    198 Grove Hall Court
    Hall Road St Johns Wood
    NW8 9NX London
    British72077700001
    HANOVER SECRETARIES LIMITED
    Apollo House
    56 New Bond Street
    W1S 1RG London
    Segretario
    Apollo House
    56 New Bond Street
    W1S 1RG London
    8463460002
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Segretario
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    BELL, Robert
    13607 Paisley Drive
    33446 Delray Beach
    Florida
    Usa
    Amministratore
    13607 Paisley Drive
    33446 Delray Beach
    Florida
    Usa
    American59786720001
    CHEEK, Philip John
    7 Ormerod Road
    Stoke Bishop
    BS9 1BA Bristol
    Amministratore
    7 Ormerod Road
    Stoke Bishop
    BS9 1BA Bristol
    EnglandBritish78733800001
    DENNERLEIN JR, Robert Michael
    85 Chestnut Drive
    FOREIGN Wayne
    New Jersey 07470
    Usa
    Amministratore
    85 Chestnut Drive
    FOREIGN Wayne
    New Jersey 07470
    Usa
    United StatesAmerican229801200001
    FRY, Carl Duncan
    19 Ennerdale Road
    TW9 3PG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    19 Ennerdale Road
    TW9 3PG Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish71701130002
    JAFFE, Marc Alan
    415 East 52nd Street
    Apt 7b/A
    New York
    Ny 10022
    Usa
    Amministratore
    415 East 52nd Street
    Apt 7b/A
    New York
    Ny 10022
    Usa
    American68177070001
    KIRK, Colin
    10 Spratt Hall Road
    Wanstead
    E11 2RQ London
    Amministratore
    10 Spratt Hall Road
    Wanstead
    E11 2RQ London
    British85982990001
    MCARTHUR-MUSCROFT, Brian David
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Amministratore
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    EnglandBritish120812990001
    MOORE, John Colin
    22 Sampson Park
    Binfield
    RG42 4BN Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    22 Sampson Park
    Binfield
    RG42 4BN Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritish67696340002
    OOSTHOEK, Adriaan
    Klaver 15
    3941 Tj Doorn
    The Netherlands
    Amministratore
    Klaver 15
    3941 Tj Doorn
    The Netherlands
    NetherlandsDutch110643190001
    ST JOHN OF BLETSO, Anthony, Lord
    31 Hurlingham Gardens
    SW6 3PH London
    Amministratore
    31 Hurlingham Gardens
    SW6 3PH London
    British71437230001
    STEVENSON, Peter
    4118 River Forth Drive
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    Amministratore
    4118 River Forth Drive
    IRISH Fairfax
    Virginia 22030
    Usa
    Usa95905720001
    TOBIN, Michael
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    Amministratore
    Masters House
    107 Hammersmith Road
    W14 0QH London
    EnglandBritish82337350003
    WADCOCK, Trevor Anthony
    89 Victoria Road
    OX2 7QG Oxford
    Amministratore
    89 Victoria Road
    OX2 7QG Oxford
    British79133200002

    GLOBIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 18 set 2006
    Consegnato il 30 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (in Such Capacity, the Securityagent)
    Transazioni
    • 30 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed (as defined) containing a first legal mortgage over the credit balance and the company's interest in the charged account (as defined)
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 15 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Under (I) an agreement for lease dated 28TH july 2000, (ii) a lease demising 1 oliver's yard,london EC2, (iii) any agreement which is an authorised guarantee for the purpose of section 16 of the landlord and tenant (covenants) act 1995 and (iv) any overriding lease to which the company becomes entitled under section 19 of the landlord and tenant (covenants) act 1995
    Brevi particolari
    The credit balance (as defined) and the company's interest in the charged accounts.
    Persone aventi diritto
    • Colebrook Estates Limited
    Transazioni
    • 15 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed (as defined) containing a first legal mortgage over the credit balance and the company's interest in the charged account (as defined)
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 15 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (I) an agreement for lease dated 28TH july 2000, (ii) a lease demising 1 oliver's yard,london EC2, (iii) any agreement which is an authorised guarantee for the purpose of section 16 of the landlord and tenant (covenants) act 1995 and (iv) any overriding lease to which the company becomes entitled under section 19 of the landlord and tenant (covenants) act 1995
    Brevi particolari
    The credit balance (as defined) and the company's interest in the charged account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Colebrook Estates Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 17 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all monies from time to time held to the credit of the company by the bank on any account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    GLOBIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2016Data di scioglimento
    24 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0