KINGSPAN PROPERTY LIMITED

KINGSPAN PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKINGSPAN PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03620695
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Greenfield Business Park No 2
    Greenfield
    CH8 7HU Holywell
    Flintshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BANRO HOLDINGS LIMITED11 mag 200411 mag 2004
    RENAISSANCE CONSTRUCTION SYSTEMS LIMITED04 feb 200304 feb 2003
    BANRO HOLDINGS LIMITED05 mag 199905 mag 1999
    QUEENSWOOD 112 LIMITED24 ago 199824 ago 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di John Francis Treanor come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Charles Wilson come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 dic 2014

    Stato del capitale al 02 dic 2014

    • Capitale: GBP 13,306.2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Charles Wilson il 01 gen 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Dermot Mulvihill come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Pat Freeman come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Geoff Doherty come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter Wilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di John Treanor come amministratore

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed banro holdings LIMITED\certificate issued on 07/03/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 mar 2011

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 07 mar 2011

    RES15

    Cessazione della carica di Gilbert Mccarthy come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Gilbert Mccarthy come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di KINGSPAN PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KINGSPAN GROUP LIMITED
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Segretario
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    107980110001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Castleknock Golf Club
    Porterstown Road
    Castleknock
    11 Somerton
    Dublin 15
    Ireland
    Amministratore
    Castleknock Golf Club
    Porterstown Road
    Castleknock
    11 Somerton
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director161069960001
    FREEMAN, Pat
    Camaghy Hill
    Magheracloone, Carrickmacross
    Co. Monaghan
    Camaghy Hill
    Ireland
    Amministratore
    Camaghy Hill
    Magheracloone, Carrickmacross
    Co. Monaghan
    Camaghy Hill
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director159006020001
    MURTAGH, Gene
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    Amministratore
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director66920570002
    DAWSON, Helen
    6 Welford Road
    Chapel Brampton
    NN6 8AF Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    6 Welford Road
    Chapel Brampton
    NN6 8AF Northampton
    Northamptonshire
    British86219590001
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    EnglishDirector78019510001
    ZANT BOER, Ian
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    British80009300001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    AUSTEN, Patrick George
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    Amministratore
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector55015730002
    BARNES, Graham Leslie
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    Amministratore
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    UkBritishDirector14145910002
    EVANS, John Russell
    5 Wyndham Wood Close
    Fradley
    WS13 8UZ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Wyndham Wood Close
    Fradley
    WS13 8UZ Lichfield
    Staffordshire
    BritishEngineer46914950003
    EVANS, Jonathan Leslie, Dr
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    Amministratore
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    BritishEngineer42254810004
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    EnglandEnglishDirector78019510001
    FELL, Nigel Anthony Russell
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector73837700002
    MCCARTHY, Gilbert
    Forrest Haven
    Cabra, Kingscourt
    Co. Cavan
    Forrest Haven
    Ireland
    Amministratore
    Forrest Haven
    Cabra, Kingscourt
    Co. Cavan
    Forrest Haven
    Ireland
    IrelandIrishDirector155528060001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Amministratore
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Amministratore
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    O'SULLIVAN, Patrick
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116309670001
    RIDGEWELL, Brian John, Dr
    Lower Barn Fields Road
    Chedworth
    GL54 4NJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Lower Barn Fields Road
    Chedworth
    GL54 4NJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishBritishManagement Consultant52685140001
    SKIVINGTON, John
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    Amministratore
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    BritishMarketing/Sales Director66957410001
    TIPPETT, Richard William
    11 Cranleigh Gardens
    BS9 1HD Stoke Bishop
    Bristol
    Amministratore
    11 Cranleigh Gardens
    BS9 1HD Stoke Bishop
    Bristol
    British AustralianDirector97578070001
    TREANOR, John Francis
    Orchard Cottage
    Whyle Lane, Brockmanton
    HR6 0RQ Leominster
    Orchard Cottage
    England
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Whyle Lane, Brockmanton
    HR6 0RQ Leominster
    Orchard Cottage
    England
    EnglandBritishAccountant71980650001
    WILSON, Peter Charles
    Southbank Close
    22 Southbank Close
    HR1 2TQ Hereford
    22
    Herefordshire
    England
    Amministratore
    Southbank Close
    22 Southbank Close
    HR1 2TQ Hereford
    22
    Herefordshire
    England
    EnglandIrishCompany Director20983740023
    WOODLOCK, Henry
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    Amministratore
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    United KingdomBritishStructural Engineer95966360002
    WRIGHT, David
    49 Avenue Road
    LE65 2FA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    49 Avenue Road
    LE65 2FA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishDirector107062350001
    ZANT BOER, Ian
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    BritishSolicitor80009300001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    KINGSPAN PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 11 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings and the junction of bridgeman street and pleck road walsall west midlands title number WM236754.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 gen 2003
    Consegnato il 29 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 29 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 2000
    Consegnato il 02 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a manor works pleck road walsall west midlands. T/no. SF108556 & WM236754. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 01 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0