ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03621275
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 1110 LIMITED25 ago 199825 ago 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 dic 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 13/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    17 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    3 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Alison Murphy il 01 nov 2017

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Alison Murphy come amministratore in data 01 lug 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Mrs Alison Murphy come amministratore in data 01 nov 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come amministratore in data 12 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daniel George Darazsdi come amministratore in data 12 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Alison Murphy come segretario in data 12 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Roy Douglas Smith come segretario in data 12 ago 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, Alison
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    214335080001
    CLEARS, David Shaun
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish214322760001
    GLENNON, Stephen Matthew
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish88291900001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    British68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Segretario
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Segretario
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Segretario
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    170871450001
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    British39200370004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish118979720001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Amministratore
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DEVAULT, Jon
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    Amministratore
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    American63857020001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Amministratore
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FORD, Richard Guy
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    Amministratore
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    British1467170002
    GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish117846410001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Amministratore
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Amministratore
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Amministratore
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish111169560001
    POTTS, Hugh Adrian
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    Amministratore
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    UsaBritish52210510003
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SLOMAN, Roger Mark
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    Amministratore
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    British8257720002
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    STREET, Andrew John
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish36056510008
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish39200370004
    WEIDNER, John Charles
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Amministratore
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Usa74299320001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Umeco Limited
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    06 apr 2016
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 11 dic 2009
    Consegnato il 30 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Creato il 23 nov 2006
    Consegnato il 29 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Creato il 16 lug 2004
    Consegnato il 22 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derbyshire Enterprise Board (Investments) Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derbyshire County Council
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0