H.D.R. COMMERCIAL LIMITED

H.D.R. COMMERCIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàH.D.R. COMMERCIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03625642
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di H.D.R. COMMERCIAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova H.D.R. COMMERCIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di H.D.R. COMMERCIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per H.D.R. COMMERCIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Stephen Roy Baxter come amministratore in data 02 lug 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Justin Humphreys come amministratore in data 02 lug 2018

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 set 2017

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 set 2016

    23 pagine4.68

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Meadowcroft Lane Ripponden West Yorkshire HX6 4AJ

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Meadowcroft Lane Halifax Road Ripponden West Yorkshire HX6 4AJ a Deloitte Llp 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL in data 14 set 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Alan Andrew Barr come amministratore in data 23 gen 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Justin Humphreys come amministratore in data 22 ott 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2014

    Stato del capitale al 20 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 set 2013

    Stato del capitale al 30 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2012

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Matthew Barker come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Matthew Barker come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Barker come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Alan Andrew Barr come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2010

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di H.D.R. COMMERCIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARKER, Matthew Howard
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    Segretario
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    155966020001
    COOK, James Andrew
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishSales Director60395790001
    LOGAN, Richard Henry
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    BritishCompany Director65473760003
    WOODFORTH, Derek Arthur
    74 Victoria Road
    LN11 0BX Louth
    Lincolnshire
    Segretario
    74 Victoria Road
    LN11 0BX Louth
    Lincolnshire
    BritishEngineer60395740002
    WOODFORTH, Sylvia Yvonne
    47 Sandringham Drive
    LN11 0JE Louth
    Lincolnshire
    Segretario
    47 Sandringham Drive
    LN11 0JE Louth
    Lincolnshire
    BritishAdministrator60395880001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARKER, Matthew Howard
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director148223210001
    BARKER, Matthew Howard
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director148223210001
    BARR, Alan Andrew
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    ScotlandBritishDirector121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    ScotlandBritishDirector86622660005
    COOK, James Andrew
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishEngineer60395790001
    COOK, Kathryn Jane
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    Cherry Trees
    5 Westlands Avenue
    DN34 4SP Grimsby
    South Humberside
    BritishSales Director102659140001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director33223550003
    LAITHWAITE, John
    Lower Hall
    Barkisland
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lower Hall
    Barkisland
    HX4 0AG Halifax
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2100890001
    LOGAN, Richard Henry
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Greystones
    Draughton
    BD23 6EG Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director65473760003
    SWAILES, John Howard
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    14 Close Lea Way
    Rastrick
    HD6 3DF Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director29291390001
    WILKINSON, George Stuart
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Rushfield Barn
    Dairy Lane
    HG3 2QP Darley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director96558860001
    WOODFORTH, Derek Arthur
    74 Victoria Road
    LN11 0BX Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    74 Victoria Road
    LN11 0BX Louth
    Lincolnshire
    BritishEngineer60395740002
    WOODFORTH, Sylvia Yvonne
    47 Sandringham Drive
    LN11 0JE Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    47 Sandringham Drive
    LN11 0JE Louth
    Lincolnshire
    BritishAdministrator60395880001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    H.D.R. COMMERCIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 23 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee,the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 17 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land in england and wales,all plant and machinery,all rental and other income and all debts and claims now or in the future under or in connection with any lease,agreement or licence. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge and assignment of sub-agreements
    Creato il 21 mar 2006
    Consegnato il 23 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sub-agreements together with the full benefit and advantage of and all monies payable under the sub-agreements and all guarantees indemnities insurance and securities. The sub-agreements being a hire purchase agreement dated 02/03/05 with the weir hotel for miele dishwasher ref no: 16/18245005, hire purchase agreement dated 01/09/04 with college house for ipso washing machine ref no: 72003219, hire purchase dated 24/09/05 with sun healthcare LTD for ipso washing machine ref no: 65004385. for details of further sub-agreements charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 23 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 23 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 23 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 ott 2005
    Consegnato il 15 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    25 nottingham road fairfield industrial estate louth lincolnshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 15 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment of sub-agreements
    Creato il 12 ago 2005
    Consegnato il 13 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All existing and future agreements between the company and its customer(s) whereby equipment the subject of any hire purchase agreements is let on hire, together with the full benefit of all monies payable under the sub agreements,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 13 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 feb 2004
    Consegnato il 20 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being plot 25 nottingham road fairfield industrial estate louth lincs. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 20 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    H.D.R. COMMERCIAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 set 2015Inizio della liquidazione
    14 ago 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0