LINECREST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINECREST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03629650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINECREST LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova LINECREST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINECREST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LINECREST LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LINECREST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2015

    Stato del capitale al 02 ott 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 set 2014

    Stato del capitale al 11 set 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2013

    Stato del capitale al 16 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di LINECREST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188574300001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishCompany Director181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishChartered Accountant150511890001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    BritishSolicitor145920530001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    WK COMPANY SERVICES LIMITED
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    Segretario
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    101282840001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director107751890001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCeo131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishChairman38256680007
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishChief Executive131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor145920530001
    KILGOUR, Robert Dow
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    BritishCompany Director494960001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishDirector145102120001
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director71527500002
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director71527500002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    LINECREST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rhyme debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and charge
    Creato il 11 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mount lens nursing home 166 kings road belfast folio number DN93605L county down. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 11/11/04
    Creato il 11 nov 2004
    Consegnato il 01 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bath street kelty t/no FFE13639 together with the parts privileges and pertinents thereof the whole right title and interest of the chargor in and to the subjects secured by the charge and the heritable fixtures and fittings therein and thereon.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited (The Lender)
    Transazioni
    • 01 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2001
    Consegnato il 13 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate k/a mount lens nursing home 166 king's road belfast county down. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29TH october 2001 and
    Creato il 15 ott 2001
    Consegnato il 08 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the subjects known as and forming benarty view nursing home 17 rowan lea kelty fife title number FFE13639.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1999
    Consegnato il 09 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or group company to the chargee whether under the legal charge or otherwise
    Brevi particolari
    All right title estate and other interests regarding leasehold property k/a the berkshire nursing home 126 barkhamroad wokinham berks.
    Persone aventi diritto
    • Healthcare Holdings Limited
    Transazioni
    • 09 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration on 20TH april 1999 and
    Creato il 20 apr 1999
    Consegnato il 04 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease entered into or about to be entered into among healthcare holdings limited,the company and four seasons health care PLC ("the lease")
    Brevi particolari
    That area of ground at kelty in the former parish of beath,county of fife extending 0.3642 hectare; t/no ffe 013639 together with the building erected thereon known as benarty view nursing home,17 rowan lea,kelty.
    Persone aventi diritto
    • Healthcare Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1999
    Consegnato il 16 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company or group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the charge or any lease
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Healthcare Holdings Limited
    Transazioni
    • 16 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 04 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, costs, charges, expenses, liabilities and obligations whether certain or contingent which now or hereafter may be or become due, owing or incurred by the company or group company (as defined) to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons, whether under the debenture or otherwise, whether originally incurred by the company or by some other person) (the "obligations")
    Brevi particolari
    By way of (a) first legal mortgage all right title estate and other interests of the chargor in the real property being l/h alexandra nursing home park road south newton-le-willows merseyside WA12 8EX and l/h shawcross nursing home bolton road stubshaw cross ashton-in-makerfield merseyside WN4 8TU together with the fixtures thereon. By way of first fixed charge the goodwill and uncalled capital, all equipment furniture plant and machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Healthcare Holdings Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0