HONEYGROVE GROUP LIMITED

HONEYGROVE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHONEYGROVE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03630751
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Focus House
    23-25 Bell Street
    RH2 7AD Reigate
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PROPAN HOMES PUBLIC LIMITED COMPANY17 nov 199817 nov 1998
    EXCHANGELINK PUBLIC LIMITED COMPANY14 set 199814 set 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 set 2014

    Stato del capitale al 21 set 2014

    • Capitale: GBP 12,311,042.9
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 set 2013

    Stato del capitale al 24 set 2013

    • Capitale: GBP 12,311,042.9
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Oakdene House 34 Bell Street Reigate Surrey RH2 7SL* in data 09 lug 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    11 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    19 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    19 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    17 pagineAA

    legacy

    11 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    17 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return28 giu 2006

    legacy

    363(190)

    Chi sono gli amministratori di HONEYGROVE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOOT, George Robert
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    Segretario
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    English94386190001
    BOOT, George Robert
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    Amministratore
    6a Windermere Way
    RH2 0LW Reigate
    Surrey
    EnglandEnglish94386190001
    TURPIN, Carl Stephen
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Hollywood
    Warren Drive
    KT20 6PX Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish85268420001
    JOHNSON, Alexander Daniel
    31 Chandos Road
    TN1 2NY Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    31 Chandos Road
    TN1 2NY Tunbridge Wells
    Kent
    British20215740005
    NEGUS, Terence James
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    Segretario
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    British40018190003
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    British38563740001
    CHT SECRETARIES LIMITED
    Sceptre House
    169-173 Regent Street
    W1B 4JH London
    Segretario
    Sceptre House
    169-173 Regent Street
    W1B 4JH London
    57357930005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DUBOIS, James
    5 Lynwood Road
    KT17 4LF Epsom
    Surrey
    Amministratore
    5 Lynwood Road
    KT17 4LF Epsom
    Surrey
    EnglandBritish1913260001
    JOHNSON, Alexander Daniel
    1 Ben Hall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    1 Ben Hall Mill Road
    TN2 5JH Tunbridge Wells
    Kent
    British20215740008
    JOHNSON, Christopher Charles
    Combe House
    Combe Bank Drive
    TN14 6AD Sundridge
    Kent
    Amministratore
    Combe House
    Combe Bank Drive
    TN14 6AD Sundridge
    Kent
    United KingdomBritish9209400004
    NEGUS, Terence James
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    Amministratore
    The Old Nursery
    Lunghurst Road
    CR3 7HF Woldingham
    Surrey
    United KingdomBritish40018190003
    PORTER, Tony Howard
    Speldhurst
    Brittains Lane
    TN13 2NG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Speldhurst
    Brittains Lane
    TN13 2NG Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish46664400002
    RIVERS, David John Hamilton
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    Amministratore
    The Well House
    Pootings Road
    TN8 6SD Crockham Hill
    Kent
    EnglandBritish104735860001
    STREETEN, Jeremy Douglas Renwick
    Roughway Cottage
    Roughway Plaxtol
    TN11 9SN Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Roughway Cottage
    Roughway Plaxtol
    TN11 9SN Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish54753180001
    VENUS, David Anthony
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    86 Park Road
    KT2 5JZ Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish38563740001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    HONEYGROVE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 20 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Facility and Security Agent for National Westminister Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Amendment deed
    Creato il 07 mag 2008
    Consegnato il 17 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including book debts buildings fixtures plant and machinery (for details of properties charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 17 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture to a group debenture dated 21 december 2004
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 31 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 31 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed
    Creato il 20 gen 2005
    Consegnato il 26 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed to a group debenture dated 21 december 2004
    Creato il 21 dic 2004
    Consegnato il 24 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 24 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 19 set 2002
    Consegnato il 26 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0