ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED

ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03638906
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K House Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GL2 LIMITED23 ott 199823 ott 1998
    ANSTY INVESTMENTS LIMITED25 set 199825 set 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 nov 2016

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 24/11/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2016 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 036389060013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 036389060014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 036389060015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 036389060010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 036389060011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 036389060012 in pieno

    5 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 mag 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da St Crispins Duke Street Norwich Norfolk NR3 1PD a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU in data 12 mag 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Robert Rolph Baldrey come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Haworth come amministratore in data 13 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Lorna Kathleen Mendelsöhn come segretario in data 28 apr 2016

    2 pagineAP03

    legacy

    50 paginePARENT_ACC

    Bilancio annuale redatto al 25 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2015

    Stato del capitale al 21 ott 2015

    • Capitale: GBP 1,100
    SH01

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Chi sono gli amministratori di ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MENDELSÖHN, Lorna Kathleen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Segretario
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    207696890001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155690570001
    FOWEN, Yvonne Pauline
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British26389070002
    GREENAN, Shane
    Apartment 7 Normanhurst Mansions
    Vera Road
    SW6 6QN London
    Segretario
    Apartment 7 Normanhurst Mansions
    Vera Road
    SW6 6QN London
    British83755070001
    HOLMES, Julian
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    Segretario
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    British110668840001
    PASSMORE, Colin
    Little Willinford Willingford Lane
    Burwash Weald
    TN19 7HR East Sussex
    Segretario
    Little Willinford Willingford Lane
    Burwash Weald
    TN19 7HR East Sussex
    British60831650001
    SMITH, Angela Clare
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    British100635720001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Segretario nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish78328360005
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    United KingdomBritish41820960003
    CROMACK, Jason Charles Edward
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish148492510001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish130923460003
    EDGLEY, Nigel John
    Eaton Hastings House
    Eaton Hastings
    SN7 8BJ Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Eaton Hastings House
    Eaton Hastings
    SN7 8BJ Faringdon
    Oxfordshire
    British35557140001
    HODGSON, Richard
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    Amministratore
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    United KingdomBritish96788660005
    HOUSTON, Peter Richard Vivian
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    Amministratore
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    United KingdomBritish113014870001
    LIVINGS, Paul Andrew
    23 Fossil Road
    SE13 7DE London
    Amministratore
    23 Fossil Road
    SE13 7DE London
    British67924860001
    MOATE, Simon Richard
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish126182400002
    PASSMORE, Colin
    Rowbarrow Farm
    Adber
    DT9 4SF Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Rowbarrow Farm
    Adber
    DT9 4SF Sherborne
    Dorset
    EnglandBritish60831650003
    WATSON, Neil David
    22 Broadclyst Gardens
    SS1 3QP Thorpe Bay
    Amministratore
    22 Broadclyst Gardens
    SS1 3QP Thorpe Bay
    British59989560001
    WONG, Jun Tsiong
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    Amministratore
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    British72387070003
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Access Plus Limited
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    06 apr 2016
    Sheffield Airport Business Park, Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02600683
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Ii Gp Llp
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    06 apr 2016
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc335665
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Iii General Partner Llp
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    06 apr 2016
    Festival Square
    Edinburgh
    50 Lothian Road
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScottish
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc303405
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Endless Llp
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Whitehall Quay
    LS1 4BF Leeds
    3
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Partnership
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazioneOc316569
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    ACCORD OFFICE SUPPLIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownards county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 29 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 mag 2003
    Consegnato il 17 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 17 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 gen 1999
    Consegnato il 18 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0