ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED

ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàZERO WASTE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03639624
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    • (9002) /

    Dove si trova ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Rudgate Court
    Walton
    LS23 7BF Wetherby
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZERO WASTE LIMITED08 ott 199808 ott 1998
    BROOMCO (1651) LIMITED28 set 199828 set 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di A G Secretarial Limited come segretario in data 01 set 2011

    2 pagineAP04

    Stato del capitale al 29 set 2011

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Cessazione della carica di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Mawlaw Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Peter Southby come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Richard Allen come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Paul George Blackler il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul George Blackler il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Segretario
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2598128
    90084920001
    ALLEN, Richard David
    Acaster Lane
    YO23 2TD Bishopthorpe
    116
    York
    United Kingdom
    Amministratore
    Acaster Lane
    YO23 2TD Bishopthorpe
    116
    York
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director153807080001
    BLACKLER, Paul George
    28 Halfleet
    PE6 8DB Market Deeping
    Shepherds Cottage
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    28 Halfleet
    PE6 8DB Market Deeping
    Shepherds Cottage
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director120687680006
    GOUGH, Kathleen Philippa
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    BritishDeal Originator96739130001
    HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    Segretario
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    BritishFinance Director63944610001
    MCGREGOR TOWERS, Kirsty
    4 Burnside Cottages
    Rookhope
    DL13 2DB Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    4 Burnside Cottages
    Rookhope
    DL13 2DB Bishop Auckland
    County Durham
    BritishAccountant80868340001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Segretario
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ANDERSON, Bruce Kirkpatrick
    3 The Chestnuts
    Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    3 The Chestnuts
    Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant42501410001
    DOWNEY, Gary Gerard
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    Amministratore
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    BritishChief Financial Officer92121410001
    GOUGH, Kathleen Philippa
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector96739130001
    HOATHER, Hugh Allen, Dr
    Oak House
    Hassalls Lane Bridge Trafford
    CH2 4GA Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Oak House
    Hassalls Lane Bridge Trafford
    CH2 4GA Chester
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director28079330002
    HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director63944610001
    HOUGH, Robert Eric
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritishDirector38776360001
    HUNTINGTON, John Michael
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishChief Executive102172280001
    SOUTHBY, Peter John
    Brander Lodge
    Trip Lane Linton
    LS22 4HX Wetherby
    Amministratore
    Brander Lodge
    Trip Lane Linton
    LS22 4HX Wetherby
    EnglandBritishGroup Finance Director116859780002
    TIPPER, Gary William
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector125160140001
    WARD, Brian Eric
    Newton House
    Newton
    NN14 1BW Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Newton House
    Newton
    NN14 1BW Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director7938140001
    WATHEN, John
    14 Carlton Road
    CW9 5PR Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    14 Carlton Road
    CW9 5PR Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector7012810001
    WORLLEDGE, Peter John Franklin
    YO62 4LG Hovingham
    Pasture House
    North Yorkshire
    Amministratore
    YO62 4LG Hovingham
    Pasture House
    North Yorkshire
    BritishChief Executive138715540001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 mag 2006
    Consegnato il 31 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Trust deposit deed
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 04 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity or the facility letter or in respect of bonds
    Brevi particolari
    All right title and interest in the trust account and the cash collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Zurich Gsg Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 04 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter indemnity the trust deposit deed and any bond
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Zurich Gsg Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mar 1999
    Consegnato il 15 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC,as Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 15 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mar 1999
    Consegnato il 11 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0