ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03639624 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
- (9002) /
Dove si trova ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 4 Rudgate Court Walton LS23 7BF Wetherby West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ZERO WASTE LIMITED | 08 ott 1998 | 08 ott 1998 |
BROOMCO (1651) LIMITED | 28 set 1998 | 28 set 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di A G Secretarial Limited come segretario in data 01 set 2011 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Stato del capitale al 29 set 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Cessazione della carica di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mawlaw Secretaries Limited come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Southby come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Richard Allen come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul George Blackler il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul George Blackler il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
ALLEN, Richard David | Amministratore | Acaster Lane YO23 2TD Bishopthorpe 116 York United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 153807080001 | ||||||||
BLACKLER, Paul George | Amministratore | 28 Halfleet PE6 8DB Market Deeping Shepherds Cottage Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 120687680006 | ||||||||
GOUGH, Kathleen Philippa | Segretario | The Boundary Parkfield Road WA16 8NP Knutsford Cheshire | British | Deal Originator | 96739130001 | |||||||||
HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire | Segretario | 15 Moorland Road M20 6BB Manchester Lancashire | British | Finance Director | 63944610001 | |||||||||
MCGREGOR TOWERS, Kirsty | Segretario | 4 Burnside Cottages Rookhope DL13 2DB Bishop Auckland County Durham | British | Accountant | 80868340001 | |||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||
MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
ANDERSON, Bruce Kirkpatrick | Amministratore | 3 The Chestnuts Easthampstead Road RG40 2EE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 42501410001 | ||||||||
DOWNEY, Gary Gerard | Amministratore | Pheasants Walk YO61 2QS Helperby Yorkshire | British | Chief Financial Officer | 92121410001 | |||||||||
GOUGH, Kathleen Philippa | Amministratore | The Boundary Parkfield Road WA16 8NP Knutsford Cheshire | England | British | Director | 96739130001 | ||||||||
HOATHER, Hugh Allen, Dr | Amministratore | Oak House Hassalls Lane Bridge Trafford CH2 4GA Chester Cheshire | England | British | Company Director | 28079330002 | ||||||||
HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire | Amministratore | 15 Moorland Road M20 6BB Manchester Lancashire | England | British | Finance Director | 63944610001 | ||||||||
HOUGH, Robert Eric | Amministratore | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | Director | 38776360001 | ||||||||
HUNTINGTON, John Michael | Amministratore | Skelton Hall Skelton Lane Thorner LS14 1AE Leeds West Yorkshire | British | Chief Executive | 102172280001 | |||||||||
SOUTHBY, Peter John | Amministratore | Brander Lodge Trip Lane Linton LS22 4HX Wetherby | England | British | Group Finance Director | 116859780002 | ||||||||
TIPPER, Gary William | Amministratore | 33 The Avenue Sale M33 4PJ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | Director | 125160140001 | ||||||||
WARD, Brian Eric | Amministratore | Newton House Newton NN14 1BW Kettering Northamptonshire | England | British | Company Director | 7938140001 | ||||||||
WATHEN, John | Amministratore | 14 Carlton Road CW9 5PR Northwich Cheshire | England | British | Director | 7012810001 | ||||||||
WORLLEDGE, Peter John Franklin | Amministratore | YO62 4LG Hovingham Pasture House North Yorkshire | British | Chief Executive | 138715540001 | |||||||||
DLA NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 23 mag 2006 Consegnato il 31 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deposit deed | Creato il 24 set 1999 Consegnato il 04 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity or the facility letter or in respect of bonds | |
Brevi particolari All right title and interest in the trust account and the cash collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 set 1999 Consegnato il 04 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter indemnity the trust deposit deed and any bond | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 mar 1999 Consegnato il 15 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 mar 1999 Consegnato il 11 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0