PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED

PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03640733
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wsp House
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WORLDPLACE LIMITED30 set 199830 set 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ a Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF in data 19 giu 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 02 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Miles Lawrence Barnard come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Karen Anne Sewell come segretario in data 15 dic 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Mark William Naysmith come amministratore in data 15 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Karen Anne Sewell come amministratore in data 15 dic 2016

    1 pagineTM01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 036407330002

    1 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    17 pagineAA

    Nomina di Karen Anne Sewell come amministratore in data 31 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Derek Bingham come amministratore in data 31 lug 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 21 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nikolas William Weston come segretario in data 31 gen 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen John Reffitt come amministratore in data 04 dic 2015

    1 pagineTM01

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 set 2015

    Stato del capitale al 16 set 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 036407330002, creata il 29 gen 2015

    37 pagineMR01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    legacy

    74 paginePARENT_ACC

    Chi sono gli amministratori di PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEWELL, Karen Anne
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    Segretario
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    220933450001
    BARNARD, Miles Lawrence
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    EnglandBritish225925270001
    NAYSMITH, Mark William
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    ScotlandBritish79793020003
    DAVIDSON, Stanley John Embleton
    3 Beaconsfield Close
    NE25 9UW Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    3 Beaconsfield Close
    NE25 9UW Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British11275420001
    PROCTOR, Richard James
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    148263070001
    WESTON, Nikolas William
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    183329300001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    WB COMPANY SECRETARIES LIMITED
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    37945630002
    AYRES, Gregory Richard
    142 Highfield Way
    WD3 7PJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    142 Highfield Way
    WD3 7PJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United StatesBritish89962850001
    BENNETT, Joel Herbert
    128 Outrigger Mall
    IRISH Marine Del Ray
    Ca 90292
    Usa
    Amministratore
    128 Outrigger Mall
    IRISH Marine Del Ray
    Ca 90292
    Usa
    American58264870002
    BINGHAM, Stephen Derek
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish113795250003
    BURTON, Eric Charles
    9 Whinbank
    Ponteland
    NE20 9HX Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    9 Whinbank
    Ponteland
    NE20 9HX Newcastle Upon Tyne
    UkBritish41088150001
    CHEESMOND, Paul
    The Rise
    New Ridley
    NE43 7RG Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    The Rise
    New Ridley
    NE43 7RG Stocksfield
    Northumberland
    British21715410001
    FLEW, Nicholas William John
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish87392780002
    KENNEDY, Malcolm William, Dr
    39 Phillipson Memorial Building
    Princess Mary Court, Jesmond
    NE2 3BG Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    39 Phillipson Memorial Building
    Princess Mary Court, Jesmond
    NE2 3BG Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish4931890002
    MATHEWS, Timothy John
    70 Rosendale Road
    SE21 8DP London
    Amministratore
    70 Rosendale Road
    SE21 8DP London
    British97155540001
    MAZANY, Daniel Keith
    15013 Buena Vista Dr
    Leawood
    Missouri Ks 66224-3901133
    Usa
    Amministratore
    15013 Buena Vista Dr
    Leawood
    Missouri Ks 66224-3901133
    Usa
    American68825350003
    MCALISTER, David Arthur
    316 East Dudley Avenue
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    Amministratore
    316 East Dudley Avenue
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    American70575400003
    NOBLE, Andrew Christopher John
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish192017410001
    REFFITT, Stephen John
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish163544450001
    REYNOLDS, Stephen Christopher
    19 Dorset Drive
    BB7 2BQ Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    19 Dorset Drive
    BB7 2BQ Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish69314310001
    RITCHIE, William Montgomerie, Dr
    Jasmine Cottage 1 Thistledown Vale
    Ifold, Loxwood
    RH14 0TN Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Jasmine Cottage 1 Thistledown Vale
    Ifold, Loxwood
    RH14 0TN Billingshurst
    West Sussex
    EnglandBritish68771920003
    SEWELL, Karen Anne
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Amber Court
    William Armstrong Drive
    NE4 7YQ Newcastle Business Park
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish211417590001
    THORNHILL, David Lawrence
    14 Clockhouse Apartments
    Enton Hall Water Lane
    GU8 5AS Witley Godalming
    Surrey
    Amministratore
    14 Clockhouse Apartments
    Enton Hall Water Lane
    GU8 5AS Witley Godalming
    Surrey
    American75666060001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001
    WB COMPANY DIRECTORS LIMITED
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    20 Collingwood Street
    NE99 1YQ Newcastle Upon Tyne
    41947520001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    07 set 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PARSONS BRINCKERHOFF HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 gen 2015
    Consegnato il 06 feb 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transazioni
    • 06 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 ott 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Cross-guarantee and debenture
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 11 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all estates and other interest in any f/h,l/h or other immovable property and fixture thereon,all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Parsons Brinckerhoff International Inc
    Transazioni
    • 11 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0