QUOCUMQUE LIMITED
Panoramica
Nome della società | QUOCUMQUE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03642319 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUOCUMQUE LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova QUOCUMQUE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QUOCUMQUE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SHELFCO (NO.1560) LIMITED | 01 ott 1998 | 01 ott 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUOCUMQUE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per QUOCUMQUE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Quintain Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Frances Victoria Heazell il 01 dic 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Angus Alexander Dodd il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. James Michael Edward Saunders il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Ben Jenkins il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Ben Jenkins come amministratore in data 13 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Michael Edward Saunders come amministratore in data 13 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Geoffrey Carter come amministratore in data 13 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Frances Victoria Heazell come segretario in data 05 ott 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Angus Alexander Dodd come amministratore in data 27 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Maxwell David Shaw James come amministratore in data 27 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 26 feb 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di QUOCUMQUE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAZELL, Frances Victoria | Segretario | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875170001 | |||||||
DODD, Angus Alexander | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | Senior Managing Director | 201606390001 | ||||
JENKINS, Michael Ben | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 221017630001 | ||||
SAUNDERS, James Michael Edward | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | Company Director | 192568400002 | ||||
DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | Solicitor Company Secretary | 50099790003 | |||||
HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175341610001 | |||||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
E P S SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184444990001 | ||||
DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | Company Director | 35942980003 | ||||
DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | Property Fund Manager | 94124780001 | ||||
ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | Chartered Accountant | 14185110002 | |||||
GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | Fund Manager | 151855940001 | ||||
GREENSLADE, Daniel Mark | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 196504990001 | ||||
HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | Director | 84913850002 | ||||
JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Company Director | 164108510003 | ||||
RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | Chartered Surveyor | 94724020002 | |||||
SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | Solicitor | 43632680001 | ||||
STEARN, Richard James | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 94050800002 | ||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | Accountant | 130493170001 | ||||
WYATT, Adrian Roger | Amministratore | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | Director | 42858810002 | ||||
MIKJON LIMITED | Amministratore delegato nominato | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di QUOCUMQUE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintain Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
QUOCUMQUE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge security agreement | Creato il 14 mar 2008 Consegnato il 17 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 04 feb 2008 Consegnato il 15 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 29 gen 2008 Consegnato il 07 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 29 gen 2008 Consegnato il 01 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 22 ott 2007 Consegnato il 25 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 09 giu 2004 Consegnato il 15 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 02 giu 2004 Consegnato il 04 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0