MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED

MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03644502
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    • Trasporto merci via acqua costiera e marittima (50200) / Trasporto e stoccaggio
    • Altre attività di supporto ai trasporti (52290) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDOCHINA SHIP MANAGEMENT (UK) LIMITED11 apr 200211 apr 2002
    LOTHIAN SHIP MANAGEMENT LIMITED 22 giu 200022 giu 2000
    LOTHIAN YEAR 2000 LIMITED06 ott 199806 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da * 25 Moorgate London EC2R 6AY England* in data 04 set 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Cessazione della carica di Kit Mok come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Charles Goodson Maltby come amministratore

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mag 2013

    Stato del capitale al 23 mag 2013

    • Capitale: GBP 1,002
    SH01

    Cessazione della carica di Sainath Venkatrao come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Kit Ting Kitty Mok come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alastair Evitt come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Indirizzo della sede legale modificato da * 10 Duke Street Liverpool L1 5AS* in data 07 dic 2012

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATERSON, Ian
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Segretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    154664870001
    DEAN, Anthony Michael
    Floor
    34 Brook Street
    W1K 5DN London
    3rd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    34 Brook Street
    W1K 5DN London
    3rd
    United Kingdom
    United KingdomBritish131254660002
    JOSEPHY, Nicholas Lawrence
    Floor
    34 Brook Street
    W1K 5DN London
    3rd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    34 Brook Street
    W1K 5DN London
    3rd
    United Kingdom
    EnglandBritish98777550002
    MALTBY, Charles Goodson
    Floor
    Swan House 17-19 Stratford Place
    W1C 1BQ London
    7th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Swan House 17-19 Stratford Place
    W1C 1BQ London
    7th
    United Kingdom
    EnglandBritish111604590001
    WHITE, Nicholas James
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    United KingdomBritish82453300001
    DAVIS, John Gordon
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    Segretario
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    British11455100002
    GORDON, Christopher
    40 Whitmore Road
    HA1 4AD Harrow
    Middlesex
    Segretario
    40 Whitmore Road
    HA1 4AD Harrow
    Middlesex
    British6571210002
    ROWAT, Peter Gordon
    59 Sea View Avenue
    West Mersea
    CO5 8BY Colchester
    Essex
    Segretario
    59 Sea View Avenue
    West Mersea
    CO5 8BY Colchester
    Essex
    British50046610001
    TAGGART, Christopher Michael
    Lynton Drive
    PR8 4QP Southport
    15
    Merseyside
    Segretario
    Lynton Drive
    PR8 4QP Southport
    15
    Merseyside
    British148192870001
    WING, Shiu
    Flat B 20/F Block 2
    Richland Gardens Kowloon Bay
    Kowloon
    Hong Kong
    Segretario
    Flat B 20/F Block 2
    Richland Gardens Kowloon Bay
    Kowloon
    Hong Kong
    British80928960001
    BIBBY BROS. & CO. (MANAGEMENT) LIMITED
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    153567030002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House 20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario
    Temple House 20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    49740370001
    BIBBY, Michael James, Sir
    Johnswood
    Margarets Lane, Childer Thornton
    CH66 5PF Ellesmere Port
    Cheshire
    Amministratore
    Johnswood
    Margarets Lane, Childer Thornton
    CH66 5PF Ellesmere Port
    Cheshire
    United KingdomBritish26373310002
    CAURO, Olivier
    8-10b Paeos De Los Tiles
    08034 Barcelona
    Spain
    Amministratore
    8-10b Paeos De Los Tiles
    08034 Barcelona
    Spain
    French70572860002
    CHATERS, David
    22 Augustine Way
    Bicknacre
    CM3 4ET Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    22 Augustine Way
    Bicknacre
    CM3 4ET Chelmsford
    Essex
    British82452230001
    CLEAVE, Nigel Derrent
    17 Spyrou Kyprianou Avenue
    P O Box 54959
    CY-3729 Limassol
    Epic House
    Cyprus
    Amministratore
    17 Spyrou Kyprianou Avenue
    P O Box 54959
    CY-3729 Limassol
    Epic House
    Cyprus
    British120876930002
    DAVIS, John Gordon
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritish11455100002
    DAVIS, John Gordon
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ginge House
    Ginge
    OX12 8QS Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritish11455100002
    DEAN, Anthony Michael
    53 Victoria Park Road
    FOREIGN Singapore
    266527
    Amministratore
    53 Victoria Park Road
    FOREIGN Singapore
    266527
    British114816080001
    EVITT, Alastair Scott
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    Amministratore
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    England
    EnglandBritish97539580002
    FOSTER, Anthony
    15 Ambassador House
    Carlton Hill
    NW8 0NJ London
    Amministratore
    15 Ambassador House
    Carlton Hill
    NW8 0NJ London
    British93756300001
    GRAY, Peter Malcolm
    28 Lugard Road
    The Peak
    Hong Kong
    Amministratore
    28 Lugard Road
    The Peak
    Hong Kong
    British73794190001
    GREEN, Cyril Joseph
    15 Latchford Road
    Gayton
    CH60 3RN Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    15 Latchford Road
    Gayton
    CH60 3RN Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish76066290001
    JOHNSON, Michael Anthony
    The Drove
    West Tytherley
    SP5 1NX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Drove
    West Tytherley
    SP5 1NX Salisbury
    Wiltshire
    British40772040001
    KITCHEN, Simon Jeremy
    2 Owls Close
    CB2 4PL Whittlesford
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Owls Close
    CB2 4PL Whittlesford
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish32549280001
    KOCHERLA, Chanakya
    Floor
    Swan House 17-19 Stratford Place
    W1C 1BQ London
    7th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Swan House 17-19 Stratford Place
    W1C 1BQ London
    7th
    United Kingdom
    AustraliaIndian135675320002
    LAING, David
    49 Dalton Street
    AL3 5QH St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    49 Dalton Street
    AL3 5QH St. Albans
    Hertfordshire
    British82452210001
    MCBROOM, Ian James
    Unicom Management Services (Cyprus)
    Limited PO BOX 6674
    FOREIGN Limassol
    Cyprus
    Amministratore
    Unicom Management Services (Cyprus)
    Limited PO BOX 6674
    FOREIGN Limassol
    Cyprus
    British60527150003
    MCCULLOCH, Stuart John
    14 Saint Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    Amministratore
    14 Saint Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish89615490001
    MOK, Kit Ting Kitty
    Hutchison House
    10 Harcourt Road
    Central
    7/F
    Hong Kong
    Amministratore
    Hutchison House
    10 Harcourt Road
    Central
    7/F
    Hong Kong
    Hong KongBritish176971040001
    OSBORNE, Jonathan
    16 Marine Crescent
    Waterloo
    L22 8QP Liverpool
    Amministratore
    16 Marine Crescent
    Waterloo
    L22 8QP Liverpool
    EnglandBritish61591800003
    PHILLIPS, Donald Jeffrey
    12a Block 2, Tam Towers,
    25 Sha Wan Drive, Pokfulam,
    FOREIGN Hong Kong
    Amministratore
    12a Block 2, Tam Towers,
    25 Sha Wan Drive, Pokfulam,
    FOREIGN Hong Kong
    British94591410001
    PILLAI, Jayakumar Krishna
    Hutchison House
    10 Harcourt Road
    Central
    7/F
    Hong Kong
    Amministratore
    Hutchison House
    10 Harcourt Road
    Central
    7/F
    Hong Kong
    Hong KongIndian161541830001
    PREECE, Mark Alfred
    1 Broomfield Road
    TW11 9NU Teddington
    Amministratore
    1 Broomfield Road
    TW11 9NU Teddington
    British111800890001
    ROWAT, Peter Gordon
    59 Sea View Avenue
    West Mersea
    CO5 8BY Colchester
    Essex
    Amministratore
    59 Sea View Avenue
    West Mersea
    CO5 8BY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish50046610001

    MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Manager's undertaking
    Creato il 05 gen 2012
    Consegnato il 24 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to all the benefits of all policies and contracts of insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Danish Ship Finance a/S (Danmarks Skibskredit a/S) and Eksport Kredit Fonden
    Transazioni
    • 24 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Manager's undertaking
    Creato il 25 ago 2011
    Consegnato il 14 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the mortgagees under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to all the benefits of all policies and contracts of insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Danish Ship Finance a/S (Danmarks Skibskredit a/S) (as Agent, as Lender and as the Swap Provider) and Eksport Kredit Fonden (as the Risk Participant)
    Transazioni
    • 14 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A manager's undertaking
    Creato il 11 apr 2011
    Consegnato il 19 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's rights title and interest in and to all the benefit of all policies and contracts of insurance of the UK registerd ship M.V. "strait of gibraltar" o/no. 917152 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas
    Transazioni
    • 19 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Manager's undertaking
    Creato il 11 mar 2011
    Consegnato il 22 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's rights title and interest in and to all the benefit of all policies and contracts of insurances. The british registered ship M.V. "strait of messina" with official number 917176 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Danish Ship Finance a/S (Danmarks Skibskredit a/S) and Eksport Kredit Fonden
    Transazioni
    • 22 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Manager's undertaking
    Creato il 23 feb 2011
    Consegnato il 08 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's rights title and interest in and to all the benefit of all policies and contracts of insurance which expression includes all entries of the UK registered ship M.V. "strait of dover" with offical number 917020 the vessel in a protection and indemnity or war risks association which are from time to time in place or taken out or entered into by or for the benefit of the company whether in the sole name of the company or in the joint names of the company and the security trustee in respect of the vessle and the earnings or otherwise howsoever in connection with the vessel or any part thereof and all benefits thereof including claims of whatsoever nature and return of premiums.
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas
    Transazioni
    • 08 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A manager's undertaking
    Creato il 07 lug 2010
    Consegnato il 23 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's rights title and interests in and to all the benfit of all insuarnces in respect of (a) the british registered ship M.V. "humber viking" with official number 915945 and (b) the earnings of the ship or (c) otherwise in connection with the ship and all benefits thereof.
    Persone aventi diritto
    • Danish Ship Finance a/S (Danmarks Skibskredit a/S) and Eksport Kredit Fonden
    Transazioni
    • 23 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 21 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Manager’s undertaking
    Creato il 20 mag 2010
    Consegnato il 24 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of the insurances of the ship M.V. mercia official no 916493, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Agent)
    Transazioni
    • 24 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Manager’s undertaking
    Creato il 20 mag 2010
    Consegnato il 24 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of the insurances of the ship M.V. mercia official no 916493, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (Agent)
    Transazioni
    • 24 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Manager's undertaking
    Creato il 25 feb 2010
    Consegnato il 04 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subject to a senior undertaking dated 25TH february 2010 all rights title and interest in and to all the benefits of the insurances of the UK registered ship M.V. "wessex" with official no. 916354 and imo number 9457189.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 04 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Manager's undertaking
    Creato il 25 feb 2010
    Consegnato il 04 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to all the benefits of the insurances of the UK registered ship M.V. "wessex" with official no. 916354 and imo number 9457189.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 04 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Further charge
    Creato il 25 set 2009
    Consegnato il 15 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The companys rights title and interest in and to all thwe benefit of all insurances of the british registered ship M.V. "humber viking" with official number 915945.
    Persone aventi diritto
    • Danish Ship Finance a/S (Danmarks Skibskredit a/S) and Eksport Kredit Fonden
    Transazioni
    • 15 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A managers undertaking
    Creato il 28 mag 2009
    Consegnato il 01 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of the insurances of the ship M.V. maas viking no 915608 and imo no 9457165.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 01 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Managers undertaking
    Creato il 08 mag 2009
    Consegnato il 22 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of the insurances in relation to the sea leopard (ex speed one) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Securitee Trustee)
    Transazioni
    • 22 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Managers undertaking
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 12 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The benefit of insurance of each of the barbadian registered ships,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. (London Branch) (Agent)
    Transazioni
    • 12 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MERIDIAN MARINE MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2014Data di scioglimento
    28 ago 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Guy Beach
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praticante
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0