EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED

EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03644914
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    • Altre attività di servizi di informazione n.c.a. (63990) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Landmark House
    Experian Way
    NG80 1ZZ Ng2 Business Park
    Nottingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLARITYBLUE LIMITED12 mag 200312 mag 2003
    SAND TECHNOLOGY (U.K.) LIMITED03 ago 199903 ago 1999
    SAND TECHNOLOGY SYSTEMS (U.K.) LIMITED08 dic 199808 dic 1998
    HILLGATE (10) LIMITED06 ott 199806 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di Mr Alexander John Bromley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Graeme Cooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Pepper come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Colin Rutter come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Edward Pepper il 01 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2013

    Stato del capitale al 10 ott 2013

    • Capitale: GBP 10,794,001
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    17 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 mar 2012

    • Capitale: GBP 10,794,001
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Robert Hudson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    27 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANNA, Ronan
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Segretario
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Irish123153660002
    BROMLEY, Alexander John
    Experian Way
    NG80 1ZZ Ng2 Business Park
    Landmark House
    Nottingham
    United Kingdom
    Amministratore
    Experian Way
    NG80 1ZZ Ng2 Business Park
    Landmark House
    Nottingham
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director167174650001
    COOPER, Paul Graeme
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Amministratore
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    United KingdomBritishCompany Director24038500001
    CLARKE, Melanie Anne
    11 Lancelyn Gardens
    West Bridgford
    NG2 7FG Nottingham
    Segretario
    11 Lancelyn Gardens
    West Bridgford
    NG2 7FG Nottingham
    British68681710003
    DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Segretario
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    87634940001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Segretario
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    62127560001
    VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED
    39 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4SD West Malling
    Kent
    Segretario
    39 Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4SD West Malling
    Kent
    102565320001
    DUBE, Georges
    4444 Sherbrooke West Apartment 506
    Westmount H3z 1e4
    Quebec
    Canada
    Amministratore
    4444 Sherbrooke West Apartment 506
    Westmount H3z 1e4
    Quebec
    Canada
    CanadianLawyer67027810001
    FIDDIS, Richard William, Dr
    Greenways House
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Greenways House
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Northern IrelandBritishNone56820590001
    GULLIVER, John Keith
    10 Jubilee Gardens
    SG18 0JW Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    10 Jubilee Gardens
    SG18 0JW Biggleswade
    Bedfordshire
    BritishAccountant85284160001
    HUDSON, Robert Jan
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Amministratore
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    United KingdomBritishCompany Director141114020001
    MASON, Melville Edgar
    Oak Cottage
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Cottage
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    BritishCompany Director141444680001
    MCGREGOR, Ian
    28b Broadwater Down
    TN2 5NR Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    28b Broadwater Down
    TN2 5NR Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishNone83291520001
    PAINTER, Duncan
    19 Kristian Sand Way
    SG6 1TX Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Kristian Sand Way
    SG6 1TX Letchworth
    Hertfordshire
    BritishExecutive84319900001
    PEPPER, Mark Edward
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Amministratore
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    United KingdomBritishDirector125266120002
    RITCHIE, Arthur
    451 Strathcona
    H3Y 2X2 Westmount
    Quebec
    Canada
    Amministratore
    451 Strathcona
    H3Y 2X2 Westmount
    Quebec
    Canada
    CanadianExecutive63244190001
    RUTTER, Colin James
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    Amministratore
    DUBLIN17 Northern Cross
    Newenham House
    Malahide Road
    Ireland
    EnglandBritishDirector123440320001
    SAUNDERS, John Norman
    Wymund House
    46b Brook Street, Wymeswold
    LE12 6TU Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Wymund House
    46b Brook Street, Wymeswold
    LE12 6TU Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishNone17847850003
    UNITT, Andrew Vaughan
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    Amministratore
    64 Main Street
    LE74 4UU Cossington
    Hollycroft
    Leicester
    EnglandBritishFinance Director182500750001
    VAUGHAN, Andrew Derek
    Seamans Lane
    SO43 7FU Minstead
    Talbot Cottage
    Hampshire
    Amministratore
    Seamans Lane
    SO43 7FU Minstead
    Talbot Cottage
    Hampshire
    EnglandBritishChairman128752770001
    WAXMAN, Susan
    384 Metcalfe Street
    H3Z 2J4 Westmount
    Quebec
    Canada
    Amministratore
    384 Metcalfe Street
    H3Z 2J4 Westmount
    Quebec
    Canada
    CanadianExecutive63244090001
    WHELAN, Sean Patrick
    11 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    Amministratore
    11 Clonmel Road
    SW6 5BL London
    IrishInvestment Director72620360001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore
    7th Floor
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    87692860001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Amministratore
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    62127560001

    EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Re nt deposit charge deed
    Creato il 11 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of an account in the name of the company or any replacement or substitute account.
    Persone aventi diritto
    • Computer Associates UK Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 07 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2002
    Consegnato il 06 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit charge deed
    Creato il 28 ago 2001
    Consegnato il 17 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with, or arising up or in consequence of termination of, a lease of even date
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of an account held in the name of sand technology (UK) limited with national westminster bank PLC or any replacement or substitute account and as more particularly described in the rent deposit charge deed referred to above.
    Persone aventi diritto
    • Computer Associates UK Limited
    Transazioni
    • 17 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    EXPERIAN INTEGRATED MARKETING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 nov 2013Inizio della liquidazione
    12 giu 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall St
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0