OPAL METROPOLITAN LIMITED

OPAL METROPOLITAN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPAL METROPOLITAN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03648104
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GIRATION LIMITED12 ott 199812 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    47 pagineWU15

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    47 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    45 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    44 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY a 2 st Peters Square Manchester M2 3EY in data 09 ago 2017

    2 pagineAD01

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:re progress report 25/02/2015-24/02/2016
    41 pagineLIQ MISC

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    51 pagine2.33B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 gen 2014

    46 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 set 2013

    62 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    117 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    5 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* in data 18 mar 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2012

    Stato del capitale al 09 nov 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OPAL METROPOLITAN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Segretario
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Amministratore
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Amministratore
    St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL METROPOLITAN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 23 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Daisybank hall daisybank road victoria park manchester t/nos gm 812153 and gm 766209. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2002
    Consegnato il 24 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all estates or interests of the chargor in any f/h or l/h property including the f/h land and buildings on the south side of daisy bank road victoria park longsight manchester t/n GM812153 and the f/h land being ducie high school and 65 daisy bank road victoria park longsight manchester t/n GM766209. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties(The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 24 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge
    Creato il 01 nov 2001
    Consegnato il 03 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under the terms of the loan agreement dated 5TH july 2000 or otherwise and all monies due under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed legal charge phase b daisy bank hall (being blocks k/a b & c) daisy bank road victoria park longsight manchester t/no.766209.
    Persone aventi diritto
    • Creditforce Limited
    Transazioni
    • 03 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 set 2000
    Consegnato il 16 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as ducie high school and 65 daisy bank road victoria park longsight, manchester greater manchester title number GM766209.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 14 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Property namely phase a daisy bank hall (being blocks a, d and e) daisy bank road longsight manchester t/no: GM812153.
    Persone aventi diritto
    • Creditforce Limited
    Transazioni
    • 14 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 set 1999
    Consegnato il 17 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a ducie high school and 65 daisy bank road longsight manchester t/no;-GM766209 together with goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 17 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 set 1999
    Consegnato il 15 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings on the south side of daisy bank road, victoria park longsight title number GM812153. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 15 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ago 1999
    Consegnato il 13 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 13 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 mag 1999
    Consegnato il 06 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from watkin jones & son or by the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Part of that f/h land k/a ducie high school and 65 daisy bank road longsight manchester togethrer with goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OPAL METROPOLITAN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 feb 2014Fine dell'amministrazione
    12 mar 2013Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DataTipo
    25 feb 2014Inizio della liquidazione
    13 set 2019Conclusione della liquidazione
    19 feb 2020Data di scioglimento
    10 feb 2014Data della petizione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0