CANANDAIGUA LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CANANDAIGUA LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03649497 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CANANDAIGUA LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CANANDAIGUA LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CANANDAIGUA LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WALNUTGLADE LIMITED | 14 ott 1998 | 14 ott 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CANANDAIGUA LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per CANANDAIGUA LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2023 | 4 pagine | AA | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA in data 06 apr 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2022 | 4 pagine | AA | ||
Nomina di Brian Scott Bennett come segretario in data 24 giu 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Janet Faye Stewart come amministratore in data 24 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Barbara Joy Laverdi come segretario in data 24 giu 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Timothy Daniel Robins come amministratore in data 24 giu 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Oksana Sandy Dominach come amministratore in data 24 giu 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Michael Jason Reitz come amministratore in data 24 giu 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2021 | 4 pagine | AA | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2020 | 4 pagine | AA | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2019 | 4 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 28 feb 2018 | 15 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 28 feb 2017 | 15 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di CANANDAIGUA LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNETT, Brian Scott | Segretario | High Point Drive Building 100 14564 Victor 207 New York United States | 297374430001 | |||||||
| REITZ, Michael Jason | Amministratore | High Point Drive Building 100 14564 Victor 207 New York United States | United States | American | 297374410001 | |||||
| ROBINS, Timothy Daniel | Amministratore | High Point Drive Building 100 14564 Victor 207 New York United States | United States | American | 297374400001 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Segretario | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | British | 28396500005 | ||||||
| FONDILLER, Ronald Charles | Segretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704620001 | |||||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Segretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | 149217590001 | |||||||
| LAVERDI, Barbara Joy | Segretario | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | 159704590001 | |||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Segretario | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | British | 69554640002 | ||||||
| SORCE, David | Segretario | 3114 Elmwood Avenue Apt 11 Rochester Monroe New York 14618 Usa | American | 61324840001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| AIKENS, Peter | Amministratore | Princes Lodge BA4 5HN Shepton Mallet Somerset | British | 2228040002 | ||||||
| CARSON, Christopher | Amministratore | White Gates 11 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | British | 26602290003 | ||||||
| CHARLTON, Peter John | Amministratore delegato nominato | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||
| CHRISTENSEN, Troy | Amministratore | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | Australia | American | 130789730002 | |||||
| COLQUHOUN, Anne Therese | Amministratore | Apartment B Kings Ride House Prince Albert Drive SL5 8AQ Ascot | United Kingdom | British | 28396500005 | |||||
| CREIGHTON, Thomas Hugh | Amministratore | Apple Acre High Road CR5 3QR Chipstead Surrey | England | British | 157727790001 | |||||
| DOMINACH, Oksana Sandy | Amministratore | High Point Drive Building 100 Victor 207 Ny 14564 United States | United States | American | 227356720001 | |||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Amministratore | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| GLENNIE, Helen Margaret | Amministratore | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | 137615160001 | |||||
| HETTERICH, Francis Paul | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 147054340001 | |||||
| HODGES, Nigel Ian | Amministratore | Sonning House 2 Canns Lane TA6 6QF North Petherton Somerset | British | 75692570001 | ||||||
| KLEIN, David | Amministratore | 45 Princes Road The Alberts TW10 6DQ Richmond Surrey | American | 119928070001 | ||||||
| MALHOTRA, Deepak Kumar | Amministratore | Constellation House The Guildway Old Portsmouth Road Artington GU3 1LR Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69554640002 | |||||
| MORAMARCO, Jon | Amministratore | C8 Trinity Gate Epsom Road GU1 3PW Guildford Surrey | American | 114902210001 | ||||||
| MULLIN, Thomas Joseph | Amministratore | The Guildway Old Portsmouth Road GU3 1LR Guildford Accolade House Surrey United Kingdom | United States | American | 159705480001 | |||||
| PETERS, Richard David | Amministratore | Rose Cottage, Upper House Lane Shamley Green GU5 0SX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 60630980002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| SANDS, Richard | Amministratore | 14 Elmwood Hill Lane 14610 Rochester Monroe New York Usa | American | 61324680002 | ||||||
| SANDS, Robert | Amministratore | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | United States | American | 61470160001 | |||||
| STEWART, Janet Faye | Amministratore | High Point Drive Building 100 Victor 207 Ny 14564 United States | United States | American | 227357690001 | |||||
| SUMMER, Thomas | Amministratore | 1196 Clover Street Rochester Monroe New York 14610 Usa | American | 61324970001 | ||||||
| TOWNSEND, Daniel Warwick | Amministratore | Folly Cottage Orchard Lane BS3 4GF Chewton Mendip Somerset | United Kingdom | British | 103574520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CANANDAIGUA LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands Inc | 06 apr 2016 | High Point Drive Building 100 Victor 207 Ny 14564 United States | No | ||||||||
| |||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||
CANANDAIGUA LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage of shares | Creato il 05 giu 2006 Consegnato il 14 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from constellation brands to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The chargeable shares and the share accruals with all dividends and other amounts paid or payable. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 22 dic 2004 Consegnato il 06 gen 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys whstsoever due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The chargeable shares,share accruals with all dividends and other amounts payable theren. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A mortgage of shares | Creato il 27 mar 2003 Consegnato il 09 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The chargeable shares and the share accruals provided that all dividends and other amounts paid ot payable constituting share accruals. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share mortgage | Creato il 06 ott 1999 Consegnato il 22 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of any loan document | |
Brevi particolari All the shares meaning any dividend income stock share security right moneys or property which may accrue be offered or otherwise derive from a share (whether by way of redemption bonus preference option or otherwise. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 14 dic 1998 Consegnato il 31 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders on any account whatsoever under any loan document | |
Brevi particolari The chargeable shares,the share accruals,the share income and all of the chargors rights against crest in respect of the dematerialised shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0