CANANDAIGUA LIMITED

CANANDAIGUA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCANANDAIGUA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03649497
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CANANDAIGUA LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CANANDAIGUA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CANANDAIGUA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WALNUTGLADE LIMITED14 ott 199814 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di CANANDAIGUA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per CANANDAIGUA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2023

    4 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA in data 06 apr 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2022

    4 pagineAA

    Nomina di Brian Scott Bennett come segretario in data 24 giu 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Janet Faye Stewart come amministratore in data 24 giu 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barbara Joy Laverdi come segretario in data 24 giu 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Timothy Daniel Robins come amministratore in data 24 giu 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Oksana Sandy Dominach come amministratore in data 24 giu 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Michael Jason Reitz come amministratore in data 24 giu 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2021

    4 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2020

    4 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2019

    4 pagineAA

    Bilancio redatto al 28 feb 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 feb 2017

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CANANDAIGUA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENNETT, Brian Scott
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    Segretario
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    297374430001
    REITZ, Michael Jason
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    Amministratore
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    United StatesAmerican297374410001
    ROBINS, Timothy Daniel
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    Amministratore
    High Point Drive
    Building 100
    14564 Victor
    207
    New York
    United States
    United StatesAmerican297374400001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Segretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    FONDILLER, Ronald Charles
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704620001
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Segretario
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    149217590001
    LAVERDI, Barbara Joy
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    159704590001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Segretario
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    British69554640002
    SORCE, David
    3114 Elmwood Avenue Apt 11
    Rochester Monroe New York
    14618
    Usa
    Segretario
    3114 Elmwood Avenue Apt 11
    Rochester Monroe New York
    14618
    Usa
    American61324840001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    AIKENS, Peter
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    Amministratore
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    British2228040002
    CARSON, Christopher
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    British26602290003
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CHRISTENSEN, Troy
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    AustraliaAmerican130789730002
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Amministratore
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritish28396500005
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish157727790001
    DOMINACH, Oksana Sandy
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    Amministratore
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    United StatesAmerican227356720001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Amministratore
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    GLENNIE, Helen Margaret
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish137615160001
    HETTERICH, Francis Paul
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican147054340001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Amministratore
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    British75692570001
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    American119928070001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Constellation House The Guildway
    Old Portsmouth Road Artington
    GU3 1LR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69554640002
    MORAMARCO, Jon
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    C8 Trinity Gate
    Epsom Road
    GU1 3PW Guildford
    Surrey
    American114902210001
    MULLIN, Thomas Joseph
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    United StatesAmerican159705480001
    PETERS, Richard David
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Rose Cottage, Upper House Lane
    Shamley Green
    GU5 0SX Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish60630980002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SANDS, Richard
    14 Elmwood Hill Lane
    14610 Rochester Monroe New York
    Usa
    Amministratore
    14 Elmwood Hill Lane
    14610 Rochester Monroe New York
    Usa
    American61324680002
    SANDS, Robert
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    United StatesAmerican61470160001
    STEWART, Janet Faye
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    Amministratore
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    United StatesAmerican227357690001
    SUMMER, Thomas
    1196 Clover Street
    Rochester Monroe New York
    14610
    Usa
    Amministratore
    1196 Clover Street
    Rochester Monroe New York
    14610
    Usa
    American61324970001
    TOWNSEND, Daniel Warwick
    Folly Cottage
    Orchard Lane
    BS3 4GF Chewton Mendip
    Somerset
    Amministratore
    Folly Cottage
    Orchard Lane
    BS3 4GF Chewton Mendip
    Somerset
    United KingdomBritish103574520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CANANDAIGUA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Constellation Brands Inc
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    06 apr 2016
    High Point Drive
    Building 100
    Victor
    207
    Ny 14564
    United States
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneDelaware, Usa
    Autorità legaleDelaware
    Luogo di registrazioneDelaware
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CANANDAIGUA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 05 giu 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from constellation brands to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargeable shares and the share accruals with all dividends and other amounts paid or payable.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys whstsoever due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargeable shares,share accruals with all dividends and other amounts payable theren. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Jpmorgan Chase Bank
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A mortgage of shares
    Creato il 27 mar 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargeable shares and the share accruals provided that all dividends and other amounts paid ot payable constituting share accruals.
    Persone aventi diritto
    • The Jp Morgan Chase Bank
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share mortgage
    Creato il 06 ott 1999
    Consegnato il 22 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of any loan document
    Brevi particolari
    All the shares meaning any dividend income stock share security right moneys or property which may accrue be offered or otherwise derive from a share (whether by way of redemption bonus preference option or otherwise.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bankas Agent and Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 22 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 14 dic 1998
    Consegnato il 31 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders on any account whatsoever under any loan document
    Brevi particolari
    The chargeable shares,the share accruals,the share income and all of the chargors rights against crest in respect of the dematerialised shares.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bankas Adminstrative Agent for the Lenders (As Defined)
    Transazioni
    • 31 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0