ENERGIS HOLDINGS LIMITED

ENERGIS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENERGIS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03649524
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THISTLEDEW LIMITED14 ott 199814 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 16 mag 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 28/03/2017
    RES13

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    16 pagineAA

    legacy

    207 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    207 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Tarek Sayed come amministratore in data 14 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Mullock come amministratore in data 14 dic 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2015

    Stato del capitale al 27 ott 2015

    • Capitale: GBP 177,466,227
    SH01

    Cessazione della carica di Alan Royston Kinch come amministratore in data 30 nov 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kerry Phillip come amministratore in data 13 gen 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Vodafone Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 12 gen 2015

    2 pagineAP02

    Nomina di Richard Mullock come amministratore in data 12 gen 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    9 pagineAA

    Nomina di Kerry Phillip come amministratore in data 01 set 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    SAYED, Tarek
    Cypress Court
    GU25 4TB Virginia Water
    1
    England
    England
    Amministratore
    Cypress Court
    GU25 4TB Virginia Water
    1
    England
    England
    United KingdomBritish215751210001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    COOPER, Nicholas Ian
    7th Floor The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1LA London
    Segretario
    7th Floor The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1LA London
    British122128470001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Segretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MCKELVIE, Andrew Laurence
    110 Osborne Road
    BN1 6LU Brighton
    East Sussex
    Segretario
    110 Osborne Road
    BN1 6LU Brighton
    East Sussex
    British60126680002
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152559570001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Amministratore
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    GRABINER, Michael
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    Amministratore
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    United KingdomBritish82032360001
    HIBBERT, John Christopher
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    Amministratore
    The Moat House
    Hoxne
    IP21 5AZ Eye
    Suffolk
    British6236200001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Amministratore
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    MORGAN, Nicola Jane
    58 Farnham Road
    GU2 4PE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    58 Farnham Road
    GU2 4PE Guildford
    Surrey
    British123399870001
    MULLOCK, Richard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish193570430001
    NORMAN, Archibald John
    Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    British69649430002
    O'HARE, Eamonn
    Oldbury Court
    Houston Way
    RG45 6BY Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    Oldbury Court
    Houston Way
    RG45 6BY Crowthorne
    Berkshire
    British90680120001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Amministratore
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    PLUTHERO, John
    Lakeside House
    Cain Road
    RG12 1XL Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Lakeside House
    Cain Road
    RG12 1XL Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish123920610001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TRENT, William Edward James
    57 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    Amministratore
    57 Rosslyn Hill
    Hampstead
    NW3 5UQ London
    United KingdomBritish81249170001
    WICKHAM, David Ian
    Galleons
    16 Homestead Road
    BR6 6HW Orpington
    Kent
    Amministratore
    Galleons
    16 Homestead Road
    BR6 6HW Orpington
    Kent
    EnglandBritish68123400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENERGIS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4434524
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ENERGIS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of debenture and assignment between the company, chelys limited and energis communications limited and the security trustee
    Creato il 16 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The "Security Trustee" or the "Agent")
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture and assignment between energis holdings limited (the "company") energis communications limited (the "initial guarantor") and the security trustee (as defined)
    Creato il 03 gen 2002
    Consegnato il 14 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property being the north block 185 park street london SE1 2ND floor south block 185 park street london SE1 3RD floor south block 185 park street london SE1 for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties(The "Security Trustee" or the "Agent")
    Transazioni
    • 14 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture and assignment
    Creato il 16 dic 1998
    Consegnato il 30 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under or in connection with each financing document (as defined in the deed) or the debenture and other charges
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank(As Agent and Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 30 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0