KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED

KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03654031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Dove si trova KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Astute House
    Wilmslow Road
    SK9 3HP Wilmslow
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KELVIC HOLDINGS LIMITED21 ott 199821 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2018

    17 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    20 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2017

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2016

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2015

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2014

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2013

    9 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 26 gen 2012

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 nov 2012

    8 pagine4.68

    legacy

    2 pagineLQ02

    legacy

    3 pagineLQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Coach House Tyersal Hall Farm Tyersal Lane Bradford West Yorkshire BD4 0RE* in data 20 dic 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    15 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 nov 2011

    LRESEX

    Bilancio annuale redatto al 21 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 feb 2010

    Stato del capitale al 18 feb 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Simon Baker il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Stewart Blackburn il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2008

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAKER, Simon
    57 Wesley Street
    WF5 8EU Ossett
    West Yorkshire
    Segretario
    57 Wesley Street
    WF5 8EU Ossett
    West Yorkshire
    British116601610001
    BLACKBURN, Robert Stewart
    270a Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    270a Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish109418670001
    BLACKBURN, Louise Claire
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    Segretario
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    British107374150001
    NELSON, Mark Richard
    21 The Lilacs
    Guiseley
    LS20 9ER Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    21 The Lilacs
    Guiseley
    LS20 9ER Leeds
    West Yorkshire
    British107373910001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BLACKBURN, Louise Claire
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cowcliffe Hill Road
    HD2 2NE Huddersfield
    270a
    West Yorkshire
    British107374150001
    BLACKBURN, Robert Stewart
    3 Moorside Street Abb Scott Lane
    Low Moor
    BD12 0EN Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Moorside Street Abb Scott Lane
    Low Moor
    BD12 0EN Bradford
    West Yorkshire
    British61676090001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 26 gen 2009
    Consegnato il 10 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Phoenix park sports ground, daleside road, pudsey, t/no WYK298998.
    Persone aventi diritto
    • Harpmanor Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 217 feb 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 217 feb 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 2
    Mortgage debenture
    Creato il 26 gen 2009
    Consegnato il 10 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    £200,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h land k/a land and buildings at phoenix park, sports complex, daleside road, thornbury, bradford west yorkshire WYK298998 together with floating security its undertaking and all its property assets and rights whatsoever see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Harpmanor Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    £64,750 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a 8-16 (even) nelson street and 27-29 (odd) wellington road, dewsbury and back nelson street, dewsbury.
    Persone aventi diritto
    • Oakapple Estates Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 2008
    Consegnato il 28 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 8-16 (even) nelson street dewsbury & 27-29 (odd) wellington road dewsbury t/no's WYK627704 & WYK258522 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 2008
    Consegnato il 15 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    £600,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Church house 12A north parade bradford.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 15 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 8 henry street, huddersfield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 23 ago 2007
    Consegnato il 25 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 10 well lane batley t/no WYK501239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2007
    Consegnato il 21 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 21 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 120 deal burn road low moor bradford west yorkshire t/n WYK772732. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2006
    Consegnato il 08 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2006
    Consegnato il 17 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 120 dealburn road, low moor, bradford.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 giu 2006
    Consegnato il 09 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 120 dealburn road low moor bradford t/n WYK772732. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cheval Property Developments Limited
    Transazioni
    • 09 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KELVIC HOLDINGS & DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2011Inizio della liquidazione
    07 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Praticante
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Tracy M Clowry
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Praticante
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Gareth Hunt
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    Praticante
    Astute House Wilmslow Road
    SK9 3HP Handforth
    Cheshire
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Beesley
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire
    Ricevitore/gestore
    Astute House Wilmslow Road
    Handforth
    SK9 3HP Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0