INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03657126 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JBS COMPUTER SERVICES LIMITED | 05 feb 1999 | 05 feb 1999 |
| GW 1000 LIMITED | 27 ott 1998 | 27 ott 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Denise Williams come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Barbara Ann Firth come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Kerry Jane Crompton il 16 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* in data 14 mag 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Segretario | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176951330001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| CHALLINGER, Sara | Segretario | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| DEAKIN, David Raymond | Segretario | 11 Witherford Way Selly Oak B29 4AY Birmingham | British | 77919810002 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Segretario | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Segretario | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| GW SECRETARIES LIMITED | Segretario | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710001 | |||||||
| BARNETT, Gary Michael | Amministratore | 27 Gloucester Road WS5 3PL Walsall West Midlands | British | 27665970001 | ||||||
| BLASDALE, Brian John | Amministratore | Springbrook House Spring Lane, Lapworth B94 5NS Solihull | British | 25611010002 | ||||||
| BOAG, Colin Mckinnon | Amministratore | 26 Downlands Way South Wonston SO21 3HS Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 40646640001 | |||||
| BRAZIER, Barry Allen | Amministratore | 30 Knighton Road B74 4NX Sutton Coldfield West Midlands | British | 62375560002 | ||||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| DEMPSEY, Simon Joseph | Amministratore | Main Road Wigginton B79 9DS Tamworth The Old Vicarage Staffs | England | United Kingdom | 113103110003 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Amministratore | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| JONES, Malcolm David | Amministratore | 8 Hillwood Common Road B75 5QJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 73250170002 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Amministratore | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Amministratore | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PILECKA, Jolanta | Amministratore | 15 Mallard Place TW1 4SW Twickenham Middlesex | United Kingdom | Polish | 90593990001 | |||||
| PREEDY, Richard Ian | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| ST JOHN, Neil | Amministratore | 4 Broom Close Wath Upon Dearne S63 7JU Rotherham South Yorkshire | British | 71857040001 | ||||||
| VELUSSI, Luca | Amministratore | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Italian | 113413330003 | |||||
| WELLS, Colin Kenelm | Amministratore | Applecross House WV15 6NB Alveley Salop | United Kingdom | British | 115361810001 | |||||
| GW INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore | Windsor House 3 Temple Row B2 5JR Birmingham West Midlands | 68279000001 |
INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 02 ott 2007 Consegnato il 15 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation | Creato il 05 dic 2000 Consegnato il 07 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The terms of fixed and floating charge dated 27TH january 1999 were amended so that the definition of "loan notes" now reads "the £500,000 units of secured loan notes 2003 of £1 each issued by the company in favour of the lender". The parties confirmed that the loan notes,as re-defined, will fall within the definition of "principal sum" (being part of the amount secured) in the fixed and floating charge dated 27 january 1999 | |
Brevi particolari As set out in the fixed and floating charge dated 27TH january 1999. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 22 mar 1999 Consegnato il 26 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19 march 1999 | |
Brevi particolari A floating charge, all book debts full benefit of the rights and remedies charged assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 27 gen 1999 Consegnato il 12 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as gw 1000 limited to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari L/H 5TH floor kingston house 438 high street west bromwich west midlands B70 9LD. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 27 gen 1999 Consegnato il 11 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as gw 1000 limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0