INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03657126
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JBS COMPUTER SERVICES LIMITED05 feb 199905 feb 1999
    GW 1000 LIMITED27 ott 199827 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 27 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 900,156.74
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Denise Williams come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Barbara Ann Firth come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario

    2 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012

    3 pagineCH01

    Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Kerry Jane Crompton il 16 mag 2012

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* in data 14 mag 2012

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951330001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    DEAKIN, David Raymond
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    Segretario
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    British77919810002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Segretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Segretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    BARNETT, Gary Michael
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    British27665970001
    BLASDALE, Brian John
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    Amministratore
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    British25611010002
    BOAG, Colin Mckinnon
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish40646640001
    BRAZIER, Barry Allen
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British62375560002
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DEMPSEY, Simon Joseph
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    Amministratore
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    EnglandUnited Kingdom113103110003
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    JONES, Malcolm David
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British73250170002
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    ST JOHN, Neil
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    British71857040001
    VELUSSI, Luca
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomItalian113413330003
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Amministratore
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    68279000001

    INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation
    Creato il 05 dic 2000
    Consegnato il 07 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The terms of fixed and floating charge dated 27TH january 1999 were amended so that the definition of "loan notes" now reads "the £500,000 units of secured loan notes 2003 of £1 each issued by the company in favour of the lender". The parties confirmed that the loan notes,as re-defined, will fall within the definition of "principal sum" (being part of the amount secured) in the fixed and floating charge dated 27 january 1999
    Brevi particolari
    As set out in the fixed and floating charge dated 27TH january 1999.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 22 mar 1999
    Consegnato il 26 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19 march 1999
    Brevi particolari
    A floating charge, all book debts full benefit of the rights and remedies charged assets.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 gen 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as gw 1000 limited to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H 5TH floor kingston house 438 high street west bromwich west midlands B70 9LD. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 27 gen 1999
    Consegnato il 11 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as gw 1000 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2014Inizio della liquidazione
    05 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0