TSO PROPERTY LIMITED
Panoramica
Nome della società | TSO PROPERTY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03658734 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TSO PROPERTY LIMITED?
- Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari
Dove si trova TSO PROPERTY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Aldgate Tower 2 Leman Street E1 8FA London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TSO PROPERTY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CASTLEALTER LIMITED | 29 ott 1998 | 29 ott 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TSO PROPERTY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per TSO PROPERTY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 29 st John's Lane London EC1M 4NA a Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA in data 01 giu 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Dudley Trood il 01 lug 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jane Li come segretario in data 04 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Exel Secretarial Services Limited come segretario in data 04 nov 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Andrew James Gunton come amministratore in data 21 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy Hamilton Hook come amministratore in data 21 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marco Alessandro Pierleoni come amministratore in data 21 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Faulkner come amministratore in data 13 mag 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Andrea Lattimore come amministratore in data 06 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Marco Alessandro Pierleoni il 27 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Stanley Coward il 27 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Duncan come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Exel Secretarial Services Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 1-5 Poland Street London W1F 8PR* in data 07 gen 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TSO PROPERTY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI, Jane | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 203109050001 | |||||||||||
COWARD, Richard Stanley | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | United Kingdom | British | Accountant | 199946190001 | ||||||||
FAULKNER, Stephen James | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Finance Director | 190049190001 | ||||||||
GUNTON, Andrew James | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Director | 201996600001 | ||||||||
HOOK, Jeremy Hamilton | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Director | 80045690001 | ||||||||
LATTIMORE, Andrea | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Risk Director | 190074140001 | ||||||||
TROOD, Stuart Dudley | Amministratore | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | England | British | Chief Financial Officer | 138486040005 | ||||||||
DELL, Richard Frederick | Segretario | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | British | Accountant | 74124260001 | |||||||||
DUNCAN, William Grant | Segretario | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | British | Group Legal Director | 75956440002 | |||||||||
JEAKINGS, Adrian Dion | Segretario | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | British | Director | 63331450001 | |||||||||
WESTERN, Peter James | Segretario | The Manor House Church Street Old Catton NR6 7DR Norwich Norfolk | British | Group Chief Accountant | 61491310003 | |||||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BURNS, Iain Keatings | Amministratore | Crow Clump Yaffle Road St Georges Hill KT13 0QF Weybridge Surrey | England | British | Company Director | 34589310001 | ||||||||
DELL, Richard Frederick | Amministratore | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | United Kingdom | British | Accountant | 74124260001 | ||||||||
DELL, Richard Frederick | Amministratore | 12 Corton Road NR32 4PL Lowestoft Suffolk | United Kingdom | British | Accountant | 74124260001 | ||||||||
DUNCAN, William Grant | Amministratore | 8 Carrington Court Limburg Road SW11 1QG London | British | Group Legal Director | 75956440002 | |||||||||
FAGANDINI, Julian Andrew | Amministratore | 68 Elsenham Street Southfields SW18 5NT London | England | British | Company Director | 46249760002 | ||||||||
HAILSTONE, Timothy Martin | Amministratore | The White Cottage Ivy Bank Swannaton Road TQ6 9RL Dartmouth Devon | United Kingdom | British | Company Director | 62539790001 | ||||||||
JEAKINGS, Adrian Dion | Amministratore | 466a Unthank Road NR4 7QJ Norwich Norfolk | Uk | British | Director | 63331450001 | ||||||||
MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald | Amministratore | Weavers Mark The Green Palgrave IP22 1AN Diss Norfolk | British | Finance Director | 50277810002 | |||||||||
PENNANT-REA, Rupert Lascelles | Amministratore | 59 Cranmer Court Whiteheads Grove SW3 3HW London | Uk | British | Company Director | 44312900002 | ||||||||
PERKINS, Frederick James | Amministratore | 25 Ham Farm Road TW10 5NA Richmond Surrey | United Kingdom | British | Director | 27861770001 | ||||||||
PIERLEONI, Marco Alessandro | Amministratore | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | England | British | Ceo Williams Lea Public Sector | 133649430001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
TSO PROPERTY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Sale contract and deed of assignment | Creato il 30 giu 2006 Consegnato il 20 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £24,300,000.00 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari The sum of 1.5 % above the base lending rate of barclays bank PLC on the completion date on the sum of £24,300,000.00 over a period of 18 months plus interest earned on the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by the stationery office holdings limited under the deep discount bond instrument | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 20 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company and/or any group company to the security benficiaries which is for the time being a party to any security document whether pursuant to the guarantee or otherwise (all as defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 22 set 1999 Consegnato il 29 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the security beneficiaries (as defined) by any charging company and/or any group company (both as defined) in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 01 apr 1999 Consegnato il 16 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness,liabilities and obligations which are as at 1ST april 1999 or may at any time thereafter be due,owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) and to the security beneficiaries (as defined) by any charging company whether actually or contingently whether pursuant to the guarantee or otherwise,whether solely or jointly with any other person and whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the relevant transaction and in whatever currency denominated including all liabilities in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,idemnities,documentary or amy instruments whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0