LIQUICO BBS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LIQUICO BBS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03658750 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LIQUICO BBS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova LIQUICO BBS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LIQUICO BBS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BANNER BUSINESS SERVICES LTD | 23 dic 2008 | 23 dic 2008 |
| BANNER BUSINESS SUPPLIES LIMITED | 03 feb 1999 | 03 feb 1999 |
| LETTERALTER LIMITED | 29 ott 1998 | 29 ott 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LIQUICO BBS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LIQUICO BBS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2019 | 6 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da K House Sheffield Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU a 15 Canada Square London E14 5GL in data 24 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione di Office2Office Limited come persona con controllo significativo il 21 set 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Endless Llp come persona con controllo significativo il 21 set 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Endless Iii General Partner Llp come persona con controllo significativo il 21 set 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Endless Ii Gp Llp come persona con controllo significativo il 21 set 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Evo Group Services Limited come persona con controllo significativo il 21 set 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Stato del capitale al 24 set 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Craig Anthony Varey come amministratore in data 09 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Rolfe come amministratore in data 09 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Office2Office Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Office2Office (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 44 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Craig Anthony Varey come amministratore in data 31 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard David Costin come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LIQUICO BBS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDELSOHN, Lorna | Segretario | Sheffield Airport Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House England | 194364060001 | |||||||
| GALE, Andrew Peter | Amministratore | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 155681500001 | |||||
| HAWORTH, Stephen | Amministratore | Sheffield Airport Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House England | England | British | 155690570001 | |||||
| CUNNINGHAM, Mark Andrew | Segretario | St Georges Hospital Road Wicklewood 16 Norfolk England | British | 130923460001 | ||||||
| RODWELL, Debra Jane Clare | Segretario | Saint Crispins House Duke Street NR3 1PD Norwich Norfolk | British | 125214030001 | ||||||
| WESTERN, Peter James | Segretario | The Manor House Church Street Old Catton NR6 7DR Norwich Norfolk | British | 61491310003 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BALDREY, Robert Rolph | Amministratore | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House United Kingdom | England | British | 78328360005 | |||||
| CALLEAR, David James | Amministratore | Barningham Hall Barningham IP31 1DH Bury St Edmunds Suffolk | England | British | 41483090001 | |||||
| CASHMAN, Mark Anthony | Amministratore | 22a Staitheway Road Wroxham NR12 8TH Norwich Norfolk | American | 63644520001 | ||||||
| COSTIN, Richard David | Amministratore | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House United Kingdom | United Kingdom | British | 134143860001 | |||||
| CUNNINGHAM, Mark Andrew | Amministratore | St Georges Hospital Road Wicklewood 16 Norfolk England | England | British | 130923460001 | |||||
| GODDARD, Mark John | Amministratore | Saint Crispins House Duke Street NR3 1PD Norwich Norfolk | England | British | 126182490001 | |||||
| HORNE, Stephen James | Amministratore | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House | United Kingdom | British | 256352360001 | |||||
| MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald | Amministratore | Weavers Mark The Green Palgrave IP22 1AN Diss Norfolk | British | 50277810002 | ||||||
| MOATE, Simon Richard | Amministratore | Saint Crispins House Duke Street NR3 1PD Norwich Norfolk | England | British | 126182400002 | |||||
| PECK, Raymond Charles | Amministratore | Springfield Pamber Road, Charter Alley RG26 5PZ Basingstoke | British | 73966840001 | ||||||
| PENNANT-REA, Rupert Lascelles | Amministratore | 59 Cranmer Court Whiteheads Grove SW3 3HW London | Uk | British | 44312900002 | |||||
| ROLFE, Jonathan | Amministratore | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House | England | British | 187225100001 | |||||
| STREETLEY, Geoffrey William | Amministratore | Reed Place Barn Dairy Lane TN12 9ST Chainhurst Kent | United Kingdom | British | 167416560001 | |||||
| VAREY, Craig Anthony | Amministratore | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House | United Kingdom | British | 223818750001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LIQUICO BBS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evo Group Services Limited | 21 set 2018 | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XU Sheffield K House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Office2office Limited | 01 dic 2016 | Europa Link S9 1XU Sheffield K House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Endless Ii Gp Llp | 06 apr 2016 | Lothian Road EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Endless Llp | 06 apr 2016 | Whitehall Quay LS1 4BF Leeds 3 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Endless Iii General Partner Llp | 06 apr 2016 | Lothian Road EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Office2office (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Sheffield Airport Business Park, Europa Link S9 1XU Sheffield K House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LIQUICO BBS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownards county down. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 30 apr 2015 | In corso | ||
Breve descrizione The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 30 apr 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 24 apr 2015 Consegnato il 28 apr 2015 | In corso | ||
Breve descrizione The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 27 nov 2014 Consegnato il 02 dic 2014 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 28 ott 2014 Consegnato il 29 ott 2014 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 apr 2008 Consegnato il 03 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 apr 2008 Consegnato il 22 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite all assets guarantee and debenture | Creato il 23 nov 2007 Consegnato il 28 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed poll and debenture | Creato il 22 lug 2002 Consegnato il 31 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group to the trustee and the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 16A crawfordsburn road newtonards county down. Broadgate (eastside) oldham broadway oldham. Part third/fourth floor st crispin's house duke street norwich (for further property charged refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 21 feb 2002 Consegnato il 04 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the deposit monies from time to time deposited pursuant to the terms of the rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 10 mag 2000 Consegnato il 12 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of part ground floor sandringham house harlow business park dated 10TH may 2000 | |
Brevi particolari Rent deposit of £13,142.25. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 apr 1999 Consegnato il 21 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LIQUICO BBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0