BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED

BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03659183
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEELRAY NO. 127 LIMITED29 ott 199829 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Roger Mclaughlan come amministratore in data 01 feb 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Mary Elizabeth Bourlet come segretario in data 01 feb 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Laura Harradine-Greene come segretario in data 01 feb 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 25 dic 2016

    3 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Mary Elizabeth Murray il 12 mag 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 03 apr 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    8 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Seconda presentazione per la cessazione di Nils Olin Steinmeyer come amministratore

    3 pagineRP04TM01

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Mary Elizabeth Murray come segretario in data 25 ago 2016

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Ward come segretario in data 13 lug 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    242726120001
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish212265950002
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    213020850002
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    GUNNING, George John
    Meadow Bank Hockering Lane
    Bawburgh
    NR9 3LR Norwich
    Norfolk
    Segretario
    Meadow Bank Hockering Lane
    Bawburgh
    NR9 3LR Norwich
    Norfolk
    British30443790001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Segretario
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    British72128340003
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    British76162020001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    173112980001
    WARD, Elizabeth Ann
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    205457410001
    STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    Segretario
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    60731070001
    BERTRAM, Richard Christiaan
    18 Ham Island
    Old Windsor
    SL4 2JY Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    18 Ham Island
    Old Windsor
    SL4 2JY Windsor
    Berkshire
    British6217370002
    BIGGS, Andrew Peter
    Woodside House
    Amport
    SP11 8BE Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Woodside House
    Amport
    SP11 8BE Andover
    Hampshire
    EnglandBritish58577370001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish195802400001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish37403500001
    GOOD, Charles Anthony
    31 Clapham Common West Side
    SW4 9AN London
    Amministratore
    31 Clapham Common West Side
    SW4 9AN London
    British6848410004
    GUNNING, George John
    Meadow Bank Hockering Lane
    Bawburgh
    NR9 3LR Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Meadow Bank Hockering Lane
    Bawburgh
    NR9 3LR Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish30443790001
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Stanmore
    Beedon
    RG20 8SR Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish72128340003
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish73644040006
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish213157990001
    KING, Wendy
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Fielden
    Abbeydale
    GL4 5EW Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish89910600001
    KITCHING, Jonathan Andrew
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    Amministratore
    Beech House
    Harp Hill
    GL52 6PR Cheltenham
    EnglandBritish68271660002
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish111439220001
    LORIMER, Alistair Martin
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Aston Cantlow Road
    Wilmcote
    CV37 9XN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish64929030001
    MARCH, Kenneth Ernest
    21 Meadowlands
    Woolpit
    IP30 9SE Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    21 Meadowlands
    Woolpit
    IP30 9SE Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish30443800001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritish1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish206428840001
    MORANT, Nicholas David
    Clenston Manor
    Winterborne Clenston
    DT11 0NX Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Clenston Manor
    Winterborne Clenston
    DT11 0NX Blandford Forum
    Dorset
    British58070440005
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish208190040001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish207509410001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish76162020001
    SAJID, Salim
    Apple Croft
    9 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    Amministratore
    Apple Croft
    9 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    British75730550003

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Blooms Of Bressingham Holdings Ltd
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06 apr 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione03892554
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BLOOMS OF BRESSINGHAM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to the debenture
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged pleas. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 01 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire, L.h land at worcester garden centre droitwich road claines worcester t/no WR101937 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.
    Persone aventi diritto
    • West Coast Capital (Hortis) Limited
    Transazioni
    • 01 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 01 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H stevenage garden centre graveley road stevenage hertfordshire, l/h land at worcester garden centre droitwich road claines worcester WR101937 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the proeprty fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 01 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Agent for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 29 mar 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Coast Capital (Hortis) Limited
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 feb 2007
    Consegnato il 24 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land on the north west of the straight mile, bourton, rugby.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a worcester garden centre, droitwich road, claines, worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a bicester garden centre, bicester, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 16 mar 2006
    Consegnato il 24 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Details of charged account: barclays bank PLC re blooms of bressingham limited current account numbered 53617580. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    St mellons park garden centre newport road cardiff t/no WA652616.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 ott 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a finebush nurseries hay lane studley grange swindon wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 24 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 mag 2001
    Consegnato il 18 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for the holders of the convertible secured loan stock of blooms of bressingham holdings PLC as the same is contributed by an instrument of even date and executed by blooms of bressingham holdings PLC
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kenneth Henry Allen
    Transazioni
    • 18 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 2000
    Consegnato il 11 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds at bicester garden centre,bicester,oxfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 11 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 2000
    Consegnato il 11 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds at bressingham,diss,norfolk. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 11 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 2000
    Consegnato il 16 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H bicester garden centre bicester oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 feb 2000
    Consegnato il 03 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 mar 1999
    Consegnato il 30 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as steelray no.127 Limited,to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plant centre building/offices and surrounding car parking/hard standing area at bressingham,diss,norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0