CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED

CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCTHL REALISATIONS 2011 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03661961
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp 2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLONNADE TOWN HOUSE HOTEL LIMITED08 gen 199908 gen 1999
    COLONNADE TOWNHOUSE HOTEL LIMITED30 ott 199830 ott 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD a Kpmg Llp 2 Forbury Place 33 Forbury Road Reading RG1 3AD in data 19 dic 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2018

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2017

    21 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2016

    22 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:re block transfer replacement of liq
    30 pagineLIQ MISC OC

    Dimissioni di un liquidatore

    1 pagine4.33

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2015

    15 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order - replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2014

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2013

    33 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 nov 2012

    41 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 nov 2011

    75 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 ott 2011

    75 pagine2.24B

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed colonnade town house hotel LIMITED\certificate issued on 01/06/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name01 giu 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 mag 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 apr 2011

    47 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRANWELL, Timiko
    Wigmore Street
    W1U 2SJ London
    78-80
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 2SJ London
    78-80
    Australian112931590003
    AL JABER, Bashayer Mohammed E
    10th Floor Al-Mahmal Tower
    Al Balad
    21474 Jeddah
    PO BOX 16645
    Saudi Arabia
    Amministratore
    10th Floor Al-Mahmal Tower
    Al Balad
    21474 Jeddah
    PO BOX 16645
    Saudi Arabia
    Saudi ArabiaSaudi Arabian128877120001
    AL JABER, Mashael Mohammed Bin Issa
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Kpmg Llp
    Amministratore
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Kpmg Llp
    Saudi ArabiaSaudi Arabian123961260001
    AL JABER, Mohamed Bin Issa
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Kpmg Llp
    Amministratore
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Kpmg Llp
    Saudi ArabiaSaudi Arabian123961930001
    BROOK, Richard James Harry
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    British43867900001
    ENGLAND, Karen Margaret
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    Segretario
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    British92797270001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    British24300100007
    BROOK, Richard James Harry
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish43867900001
    ENGLAND, Karen Margaret
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    Amministratore
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    British92797270001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish24300100007
    TYRIE, Peter Robert
    38 Seaton Close
    Putney Heath
    W9 2JE London
    Amministratore
    38 Seaton Close
    Putney Heath
    W9 2JE London
    British782150006

    CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking debenture
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 06 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2007
    Consegnato il 21 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from eton group holdings limited or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC (as Security Trustee for the Banks)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 2005
    Consegnato il 17 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property 2 warrington cresecent westminster greater london t/no ngl 463635. by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC (as Security Trustee for the Banks)
    Transazioni
    • 17 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1998
    Consegnato il 19 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 warrington crescent london W9 1ER.t/no.ngl 463635.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 1998
    Consegnato il 19 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the colonnade hotel,2 warrington crescent,westminster,london W2 1ER.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CTHL REALISATIONS 2011 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 nov 2011Fine dell'amministrazione
    17 giu 2010Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    28 nov 2011Inizio della liquidazione
    28 apr 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    RG7 4SD Theale
    Reading
    Praticante
    Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    RG7 4SD Theale
    Reading
    Allan Watson Graham
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Praticante
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Neil David Gostelow
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Praticante
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0