PIVOTPOINT EUROPE LIMITED
Panoramica
Nome della società | PIVOTPOINT EUROPE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03664685 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Sanderson House Poplar Way S60 5TR Sheffield South Yorkshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 apr 2021
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 7 Rushmills Northampton NN4 7YB England a Sanderson House Poplar Way Sheffield South Yorkshire S60 5TR in data 01 apr 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Louise Chalmers come amministratore in data 11 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin James Mcadams come amministratore in data 11 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Nicola Marrison come amministratore in data 11 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Ann Cummings come amministratore in data 11 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sanderson House Manor Road Coventry CV1 2GF England a 7 Rushmills Northampton NN4 7YB in data 04 mag 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Newcombe come amministratore in data 08 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms. Karen Louise Chalmers come amministratore in data 08 mar 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ross Telford come amministratore in data 08 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Sandra Ann Cummings come amministratore in data 08 mar 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Hellen Maria Stein come amministratore in data 08 mar 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 42 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard David Mogg come amministratore in data 13 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARRISON, Nicola | Amministratore | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 263483420001 | ||||
MCADAMS, Kevin James | Amministratore | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | United States | American | Director | 277744300001 | ||||
STEIN, Hellen Maria | Amministratore | Poplar Way S60 5TR Sheffield Sanderson House South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Emea Human Resources Director | 267152760001 | ||||
CALLE, David Graeme | Segretario | 10 Turnberry Lane Collingtree Park NN4 0PA Northampton | British | Financial Director | 81875080001 | |||||
JONES, Christopher Stuart | Segretario | Fieldview Lilbourne Lane Catthorpe LE17 6EH Lutterworth Leicestershire | British | Company Secretary | 1613910002 | |||||
KNIGHT, Peter John | Segretario | 26 Moresby Close Westlea SN5 7BX Swindon | British | Business Consultancy Manager | 61083790001 | |||||
MOORE, Lionel Philip | Segretario | Stratton Chase Drive HP8 4NS Chalfont St. Giles Stratton Chase Lodge Buckinghamshire United Kingdom | British | 31291040005 | ||||||
MORGAN, Crispin Huw | Segretario | 34 Saint Johns Street PE18 6DD Huntingdon Cambridgeshire | British | Company Secretary | 64341740001 | |||||
CALLE, David Graeme | Amministratore | 10 Turnberry Lane Collingtree Park NN4 0PA Northampton | British | Company Director | 81875080001 | |||||
CHALMERS, Karen Louise, Ms. | Amministratore | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | United Kingdom | British | Emea Human Resources Director | 265852240001 | ||||
CUMMINGS, Sandra Ann | Amministratore | Rushmills NN4 7YB Northampton 7 England | United Kingdom | British | Emea Human Resources Director | 269384760001 | ||||
HALL, Derek Alan | Amministratore | 23 Holte Drive B75 6PR Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Director | 70402050001 | |||||
HAYLES, Trevor | Amministratore | 44 Wych Elm Drive CV31 3QR Leamington Spa Warwickshire | British | Managing Director | 55296690002 | |||||
HUGGINS, Adrian Paul | Amministratore | 27 Clarence Gate IG8 8GN Woodford Green Essex | British | Solicitor | 96296180001 | |||||
KNIGHT, Peter John | Amministratore | 26 Moresby Close Westlea SN5 7BX Swindon | British | Business Consultancy Manager | 61083790001 | |||||
MOGG, Richard David | Amministratore | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House England | England | British | Group Finance Director | 159395950001 | ||||
MOORE, Lionel Philip | Amministratore | Stratton Chase Drive HP8 4NS Chalfont St. Giles Stratton Chase Lodge Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 31291040007 | ||||
NEWCOMBE, Ian | Amministratore | Manor Road CV1 2GF Coventry Sanderson House England | England | British | Director | 160222680001 | ||||
REARDON, Alan | Amministratore | 10 Berryfields Aldridge WS9 0EE Walsall West Midlands | British | Comapny Director | 50216990001 | |||||
TELFORD, Ross | Amministratore | Park House 6 Adock Drive CV8 2RB Kenilworth Warwickshire | England | British | Director | 56710820003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PIVOTPOINT EUROPE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anisa Supply Chain Solutions Limited | 06 apr 2016 | Buckingham Palace Road SW1W 9SA London 140 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PIVOTPOINT EUROPE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 03 ott 2001 Consegnato il 09 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 13 nov 2000 Consegnato il 15 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement for ibm global financing dated 2ND october 2000 | |
Brevi particolari ,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 ott 2000 Consegnato il 01 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the investors as defined in the charge pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date with the charge made between the company and others (1) and the chargee (2) (other than dividend on any shares) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 25 mag 2000 Consegnato il 06 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0