COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03665237 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (NEPTUNE) LIMITED | 04 gen 1999 | 04 gen 1999 |
LETTERCOUNT LIMITED | 10 nov 1998 | 10 nov 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent England and Wales TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Jon William Mortimore come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Fitzsimmons il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Catchpole come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808420001 | |||||||
LEWIS, Colin Edward | Amministratore | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
SHARP, Giles Henry | Amministratore | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 194659450001 | ||||
GANDHI, Devendra | Segretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Segretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MALDE, Nikunj | Segretario | 32 Northiam N12 7HA London | British | 75516880001 | ||||||
MALDE, Nishith | Segretario | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 148459300001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BROWN, Carole Elizabeth | Amministratore | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 England | England | British | Secretary | 98235420004 | ||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
DIPRE, John Vivian | Amministratore | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Director | 35117250001 | ||||
FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FOSTER, David Martin | Amministratore | Bear Park 31 Nightingale Road WD3 7DA Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Director | 50285750005 | ||||
GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Amministratore | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Director | 75350600002 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MALDE, Nishith | Amministratore | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 148459300001 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Amministratore | High Street Westerham TN16 1RG Kent 30 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
WICKS, Stephen Desmond | Amministratore | Sherwood House Oxhey Drive HA6 3EU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 42298130002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 09 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property k/a south side of tresilian avenue, winchmore hill t/no AGL89439. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 ott 2002 Consegnato il 21 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 ago 2002 Consegnato il 11 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage land on the south side of tresilian avenue winchmore hill enfield t/n AGL82307. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 dic 2001 Consegnato il 17 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of highlands village limited to the chargee pursuant to the provisions of clause 26(1) of an agreement for sale dated 29TH august 1997 as varied by a supplemental agreement dated 31ST march 1998 and a second supplemental agreement dated 14TH july 2000 | |
Brevi particolari The part of the former highlands hospital and south lodge hospital worlds end lane winchmore hill london N21 l/b of enfield t/no: AGL81528. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 07 mar 2001 Consegnato il 12 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as healthcare centre and pharmacy being land on the south side of tresilian ave,winchmore hill enfield midd'x; agl 82307. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 lug 2000 Consegnato il 21 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as part of former highlands hospital and south lodge hospital, worlds end lane, winchmore hill, london N21 being part of land in title number EGL371670. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of contract | Creato il 21 gen 1999 Consegnato il 08 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A contract of sale & purchase dated 21/1/99 in respect of the property and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0