COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED

COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03665237
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COUNTRY AND METROPOLITAN HOMES (NEPTUNE) LIMITED04 gen 199904 gen 1999
    LETTERCOUNT LIMITED10 nov 199810 nov 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 High Street Westerham Kent England and Wales TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 15 dic 2014

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2014

    Stato del capitale al 03 nov 2014

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Elizabeth Catchpole come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2013

    Stato del capitale al 04 nov 2013

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Nomina di Jon William Mortimore come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Fitzsimmons il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Elizabeth Catchpole come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Segretario
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808420001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MALDE, Nikunj
    32 Northiam
    N12 7HA London
    Segretario
    32 Northiam
    N12 7HA London
    British75516880001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Segretario
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant148459300001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    Amministratore
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    EnglandBritishSecretary98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant148459300001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Westerham
    TN16 1RG Kent
    30
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo207729000002
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector42298130002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COUNTRY & METROPOLITAN HOMES (HIGHLANDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 09 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a south side of tresilian avenue, winchmore hill t/no AGL89439. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 ott 2002
    Consegnato il 21 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ago 2002
    Consegnato il 11 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage land on the south side of tresilian avenue winchmore hill enfield t/n AGL82307. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 dic 2001
    Consegnato il 17 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of highlands village limited to the chargee pursuant to the provisions of clause 26(1) of an agreement for sale dated 29TH august 1997 as varied by a supplemental agreement dated 31ST march 1998 and a second supplemental agreement dated 14TH july 2000
    Brevi particolari
    The part of the former highlands hospital and south lodge hospital worlds end lane winchmore hill london N21 l/b of enfield t/no: AGL81528.
    Persone aventi diritto
    • Sainsbury's Supermarkets LTD
    Transazioni
    • 17 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mar 2001
    Consegnato il 12 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as healthcare centre and pharmacy being land on the south side of tresilian ave,winchmore hill enfield midd'x; agl 82307. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 lug 2000
    Consegnato il 21 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as part of former highlands hospital and south lodge hospital, worlds end lane, winchmore hill, london N21 being part of land in title number EGL371670.
    Persone aventi diritto
    • Sainsbury's Supermarkets Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of contract
    Creato il 21 gen 1999
    Consegnato il 08 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A contract of sale & purchase dated 21/1/99 in respect of the property and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Egt Finance Limited
    Transazioni
    • 08 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0