COMPUTER SOFTWARE LIMITED

COMPUTER SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOMPUTER SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03665527
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GUILDFORD MIDCO 2 LIMITED12 mag 201012 mag 2010
    COMPUTER SOFTWARE LIMITED12 lug 199912 lug 1999
    COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED26 mar 199926 mar 1999
    MAILCLEAR LIMITED11 nov 199811 nov 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 11 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 nov 2013

    Stato del capitale al 12 nov 2013

    • Capitale: GBP 464,523.75
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    7 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Nomina di Denise Williams come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mrs Barbara Ann Firth come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario

    2 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012

    3 pagineCH01

    Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* in data 14 mag 2012

    1 pagineAD01

    Memorandum e Statuto

    26 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951890001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Segretario
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Segretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Segretario
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    British68788350001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British69845130001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Segretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAGGS, Michael Vincent
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    Amministratore
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    United KingdomBritish25974780001
    BARNES, Kenneth Roy
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    Amministratore
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    British33463930001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritish158261930001
    CROSS, Neil Edward
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    Amministratore
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    EnglandBritish26042290002
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Amministratore
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish68788350001
    HOLLAND, Christopher
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    Amministratore
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    British77338810001
    JACKSON, Glenn Thomas
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    EnglandBritish38721150004
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    Amministratore
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    United KingdomBritish40521530001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    LOWE, David Andrew
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    Amministratore
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    British10441050001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    UkBritish69845130001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PINNING, Stephen Peter
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    Amministratore
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    British14848160001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, David John
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish91573380001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Amministratore
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330002
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Amministratore
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    CLARKS NOMINEES LIMITED
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    38350670001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.,London as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 lug 2004
    Consegnato il 07 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ott 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the security trsutee and/or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Elderstreet Capital Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 dic 2001
    Consegnato il 12 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 10 mag 2000
    Consegnato il 12 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £45,000 held on an account with the bank together with interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2014Inizio della liquidazione
    05 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0