HELENA KENNEDY FOUNDATION
Panoramica
| Nome della società | HELENA KENNEDY FOUNDATION |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 03667290 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HELENA KENNEDY FOUNDATION?
- Servizi di supporto all'istruzione (85600) / Istruzione
Dove si trova HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Indirizzo della sede legale | South And City College Birmingham Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HELENA KENNEDY BURSARY SCHEME | 13 nov 1998 | 13 nov 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mag 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 28 feb 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 13 nov 2025 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 27 nov 2025 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 13 nov 2024 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2025 | 22 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Julie Mary Mills come amministratore in data 20 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Rachael Shimmin come amministratore in data 20 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2024 | 21 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Ian David Kernohan come amministratore in data 08 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di John Sandiford Haigh come amministratore in data 05 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Anthony Eeles come amministratore in data 30 gen 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Paul Anthony Eeles come amministratore in data 08 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Paul Anthony Eeles come amministratore in data 23 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2023 | 21 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Rachael Shimmin Obe il 14 feb 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Rachael Shimmin il 14 feb 2024 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2022 | 21 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Memorandum e Statuto | 18 pagine | MA | ||
Nomina di Ms Rachael Shimmin come amministratore in data 08 nov 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Mica Jayne Jones il 10 nov 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Alan John Coates come amministratore in data 01 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Karen Elizabeth Mitchell come amministratore in data 30 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Vicky Duckworth come amministratore in data 08 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Rachael Shimmin come amministratore in data 15 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Ms Rachael Shimmin come amministratore in data 14 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Philip Le Feuvre come amministratore in data 15 lug 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Mark Ian | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | United Kingdom | British | 264877730001 | |||||
| HESS, Elizabeth Ann | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British,American | 264877530001 | |||||
| JONES, Mica Jayne | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 264879390005 | |||||
| LE FEUVRE, Philip James | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 295634290001 | |||||
| TCHOUDNOWSKY, Iandra Mccallum | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 264878380001 | |||||
| DAWSON, Ellen | Segretario | c/o Ellen Dawson Bletchley Park, Sherwood Drive Bletchley MK3 6EB Milton Keynes The Mansion Bucks England | 148739590001 | |||||||
| EVE, Richard John Edward | Segretario | 89 Church Road Burton Joyce NG14 5GD Nottingham Nottinghamshire | British | 84467160001 | ||||||
| GLASGOW, Jeffrey Stewart | Segretario | 34 The America CB6 2NY Sutton Cambridgeshire | British | 67728470001 | ||||||
| LIMB, Ann Geraldine, Dame | Segretario | 3 Willow Lane Stony Stratford MK11 1FG Milton Keynes Trinity House Buckinghamshire | British | 111098110001 | ||||||
| STREETING, Wesley Paul William | Segretario | University Of East London Water Lane E15 4LZ Stratford University House London United Kingdom | 155853540001 | |||||||
| ANSLOW, Hilary Margaret | Amministratore | Knot House Church Brow Walton Le Dale PR5 4BH Preston Lancashire | England | British | 38583000001 | |||||
| BORKHATARIA, Nirmal Kumar | Amministratore | The Lodge Firs Wood Close Potters Bar EN6 4BY Northaw Hertfordshire | England | British | 54491970001 | |||||
| CHOONARA, Ahmed | Amministratore | Harrow Road West Bridgford NG2 7DY Nottingham 153 Nottinghamshire | United Kingdom | British | 110984630002 | |||||
| COATES, Alan John | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 240284780001 | |||||
| COPLAND, Geoffrey Malcolm, Dr | Amministratore | 24 The Broadway Gustard Wood Wheathampstead AL4 8LN St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 58777170001 | |||||
| DAVIES, Lesley Jean | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | United Kingdom | British | 183464780001 | |||||
| DICKETTS, Sally Ann Sheila | Amministratore | The Elms High Street MK16 8EH Newport Pagnell Buckinghamshire | England | British | 60359760001 | |||||
| DUCKWORTH, Vicky, Dr | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 193832280001 | |||||
| EELES, Paul Anthony | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 62762110002 | |||||
| EELES, Paul Anthony | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 62762110002 | |||||
| EVE, Richard John Edward | Amministratore | 89 Church Road Burton Joyce NG14 5GD Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 84467160001 | |||||
| FAULKNER, Anne | Amministratore | 116 Gwydir Street CB1 2LL Cambridge Cambridgeshire | England | British | 117469290001 | |||||
| FLETCHER, Kathryn Jane | Amministratore | Basement Flat 14 Francis Terrace N19 5PY London | United Kingdom | British | 116429020001 | |||||
| FLINT, Colin | Amministratore | 35 Alderbrook Road B91 1NW Solihull West Midlands | British | 32431670001 | ||||||
| GILCHRIST, Helen Mary, Dr | Amministratore | Woodend House Keighley Road HX7 8HN Hebden Bridge West Yorkshire | British | 44555360001 | ||||||
| HAIGH, John Sandiford | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 197412060001 | |||||
| HOPKINS, Michael David | Amministratore | University Of East London Water Lane E15 4LZ Stratford University House London | England | British | 159895760003 | |||||
| HUGHES, Christopher John | Amministratore | 502 Hawkins House Dolphin Square SW1V 3NU London | United Kingdom | British | 38588290004 | |||||
| HUGHES, Paul Bonner | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 238319230001 | |||||
| JONES, Ivor | Amministratore | University Of East London Water Lane E15 4LZ Stratford University House London United Kingdom | United Kingdom | British | 114155970001 | |||||
| KERNOHAN, Ian David | Amministratore | Handsworth Campus The Council House, Soho Road B21 9DP Birmingham South And City College Birmingham England | England | British | 238319980001 | |||||
| KHEMKA, Asha, Dame | Amministratore | Needwood Manor Rangemore DE13 9RS Burton On Trent Staffordshire | England | British | 139239140002 | |||||
| KING, Christine Elizabeth, Dr | Amministratore | Eight Bells Telford Close ST15 8GJ Stone Staffordshire | United Kingdom | British | 79499360001 | |||||
| LANGTON, Tracy | Amministratore | University Of East London Water Lane E15 4LZ Stratford University House London | England | British | 215191500001 | |||||
| LEWIN, Robert Reginald | Amministratore | Colebrook Goring Road Woodcote RG8 0QE Reading | England | British | 35761440001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HELENA KENNEDY FOUNDATION?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 13 nov 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0