TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03670921 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
- fabbricazione di utensili (25730) / Industrie manifatturiere
Dove si trova TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Eversheds Llp Bridgewater Place Water Lane LS11 5DR Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ELAN MANUFACTURING LTD | 20 nov 1998 | 20 nov 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 22 set 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Moye Jr. come amministratore in data 23 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2016 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 22 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jaime Manson Easley il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Stephen Tsoris il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Thomas Moye Jr. il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Andrew Reilly come amministratore in data 26 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Jaime Manson Easley come amministratore in data 26 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Lucius Lilly come amministratore in data 03 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Stephen Tsoris come amministratore in data 03 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | 70-76 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester Eversheds House |
| 60471940015 | ||||||||||
| EASLEY, Jaime Manson | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina Usa | United States | American | 201666830001 | |||||||||
| SMELTSER, Jeremy Wade | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina Usa | United States | American | 163313000001 | |||||||||
| TSORIS, Stephen | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina Usa | United States | American | 197069810001 | |||||||||
| HALPIN, Gillian Anne | Segretario | 16 Belsay Grove NE22 5YU Bedlington Northumberland | British | 94455280001 | ||||||||||
| MILLIGAN, Susan | Segretario | 28 Scoular Drive North Seaton NE63 9SE Ashington Northumberland | British | 79430150001 | ||||||||||
| VINEBERG, Gerald | Segretario | The Cottage East Coldcoats, Ponteland NE20 0AE Newcastle Upon Tyne | British | 62422370003 | ||||||||||
| VINEBERG, Gerald | Segretario | 6 Deyncourt Close Ponteland NE20 9JY Newcastle Upon Tyne | British | 62422370002 | ||||||||||
| WALTON, Susan Mary | Segretario | 29 The Villas Stannington NE61 6AT Morpeth Northumberland | British | 61441830001 | ||||||||||
| CHANCERY BUSINESS COMMUNICATIONS LTD | Segretario | 135 Sandyford Road Jesmond NE2 1QW Newcastle Upon Tyne | 62198370006 | |||||||||||
| CAMPBELL, David | Amministratore | 43 Whittingham Close NE63 8XX Ashington | British | 74069910002 | ||||||||||
| COWAN, Judy Rosalie | Amministratore | 135 Sandyford Road NE2 1QW Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 64920970001 | ||||||||||
| FARRELL, Thomas Joseph | Amministratore | Renee Drive South Beloit 8045 Illinois 61080 United States | Usa | United States | 152188440001 | |||||||||
| FOGERTY, Robert | Amministratore | Bothal Close Pegswood NE61 6YD Morpeth 6 Northumberland England | England | British | 147361440001 | |||||||||
| LILLY, Kevin Lucius | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | Usa | United States | 110636870002 | |||||||||
| MILLICAN, Susan | Amministratore | Rectory Park NE61 2SZ Morpeth 14 Northumberland United Kingdom | British | 132210170001 | ||||||||||
| MORE, Nicholas | Amministratore | 2 Coquet Vale House Felton NE65 9PW Morpeth Northumberland | British | 70187190001 | ||||||||||
| MOYE JR., Thomas | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte Spx Flow Inc. North Carolina Usa | United States | United States | 180972020001 | |||||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13515 North Carolina Nc 28277 United States | United States | American | 61807850002 | |||||||||
| REILLY, Michael Andrew | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||||||
| VINEBERG, Gerald | Amministratore | The Cottage East Coldcoats, Ponteland NE20 0AE Newcastle Upon Tyne | England | British | 62422370003 | |||||||||
| WALTON, John Nigel | Amministratore | 29 The Villas St Marys Stannington NE61 6AT Morpeth Northumberland | British | 61712930001 | ||||||||||
| WHITMELL, David Andrew | Amministratore | 44 Grousemoor Drive NE63 8LU Ashington Northumberland | England | British | 82615370001 | |||||||||
| WILKINSON, John | Amministratore | 27 Sherburn Grange South NE32 5LS Jarrow Tyne & Wear | British | 108640850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spx International Limited | 06 apr 2016 | Bridgewater Place Water Lane LS11 5DR Leeds Eversheds Llp United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TORQUE TENSION SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 29 mar 2000 Consegnato il 01 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0