DEANMAST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEANMAST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03671397
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEANMAST LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova DEANMAST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Courtyard Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    Dorset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEANMAST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per DEANMAST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Austin John Davies il 20 ago 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Stephen John Davies come amministratore in data 20 mar 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John William Chalk come amministratore in data 20 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016

    3 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2015

    Stato del capitale al 23 nov 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Robert Keith Bendell come segretario in data 16 set 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Robert Keith Bendell come segretario in data 01 feb 2015

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2014

    Stato del capitale al 25 nov 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di DEANMAST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURGE, Hugo Aylesford
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    Segretario
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    British66350170008
    BURGE, Hugo Aylesford
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    Amministratore
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66350170008
    BURGE, Oliver Aylesford
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    Amministratore
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director19033020004
    DAVIES, Roger Max
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    Amministratore
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    United KingdomBritishCompany Director2994130001
    DAVIES, Stephen Austin John
    Norton Lane
    Chew Magna
    BS40 8RW Bristol
    North Elm House
    United Kingdom
    Amministratore
    Norton Lane
    Chew Magna
    BS40 8RW Bristol
    North Elm House
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director154569630003
    BENDELL, Robert Keith
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    Segretario
    Holt Lodge Farm
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    194755220001
    MCALISTER, Neil Stewart
    3 Yew Tree Cottages
    Cranmore Lane West Horsley
    KT24 6BU Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    3 Yew Tree Cottages
    Cranmore Lane West Horsley
    KT24 6BU Leatherhead
    Surrey
    BritishSolicitor61869590001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BURGE, Hugo Aylesford
    Flat 1 227 Ladbroke Grove
    W10 6HG London
    Amministratore
    Flat 1 227 Ladbroke Grove
    W10 6HG London
    United KingdomBritishCompany Director66350170008
    CHALK, John William
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    Amministratore
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    United KingdomBritishCompany Director74739180001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DEANMAST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Padmanor Investments Limited
    Horton Heath
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    England
    06 apr 2016
    Horton Heath
    Horton
    BH21 7JN Wimborne
    The Courtyard
    Dorset
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione01378221
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DEANMAST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 09 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or padmanor investments limited to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 138/140 old street london EC1 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares membership rights in any management company for the property any goodwill of any business and any other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 09 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become dur from the company and/or padmanor investmnts limited to the chargee
    Brevi particolari
    Thye property k/a 28/42 banner street london EC1 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any goodwill of any business and any rental and other money payable under any lease licence.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 nov 1999
    Consegnato il 02 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montague & Co. Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal charge
    Creato il 09 feb 1999
    Consegnato il 10 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tristram investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    138/140 old street london EC1 t/no: NGL673767. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party legal mortgage
    Creato il 09 feb 1999
    Consegnato il 10 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tristram investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    28/42 banner street london EC1 t/no: NGL673768. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0