DEANMAST LIMITED
Panoramica
Nome della società | DEANMAST LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03671397 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DEANMAST LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova DEANMAST LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Courtyard Holt Lodge Farm Horton BH21 7JN Wimborne Dorset |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di DEANMAST LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DEANMAST LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Austin John Davies il 20 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen John Davies come amministratore in data 20 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John William Chalk come amministratore in data 20 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Keith Bendell come segretario in data 16 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Keith Bendell come segretario in data 01 feb 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DEANMAST LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURGE, Hugo Aylesford | Segretario | Holt Lodge Farm Horton BH21 7JN Wimborne The Courtyard Dorset United Kingdom | British | 66350170008 | ||||||
BURGE, Hugo Aylesford | Amministratore | Holt Lodge Farm Horton BH21 7JN Wimborne The Courtyard Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 66350170008 | ||||
BURGE, Oliver Aylesford | Amministratore | Holt Lodge Farm Horton BH21 7JN Wimborne The Courtyard Dorset United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 19033020004 | ||||
DAVIES, Roger Max | Amministratore | 6 Brechin Place SW7 4QA London | United Kingdom | British | Company Director | 2994130001 | ||||
DAVIES, Stephen Austin John | Amministratore | Norton Lane Chew Magna BS40 8RW Bristol North Elm House United Kingdom | England | British | Property Director | 154569630003 | ||||
BENDELL, Robert Keith | Segretario | Holt Lodge Farm Horton BH21 7JN Wimborne The Courtyard Dorset | 194755220001 | |||||||
MCALISTER, Neil Stewart | Segretario | 3 Yew Tree Cottages Cranmore Lane West Horsley KT24 6BU Leatherhead Surrey | British | Solicitor | 61869590001 | |||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
BURGE, Hugo Aylesford | Amministratore | Flat 1 227 Ladbroke Grove W10 6HG London | United Kingdom | British | Company Director | 66350170008 | ||||
CHALK, John William | Amministratore | 6 Brechin Place SW7 4QA London | United Kingdom | British | Company Director | 74739180001 | ||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DEANMAST LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padmanor Investments Limited | 06 apr 2016 | Horton Heath Horton BH21 7JN Wimborne The Courtyard Dorset England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
DEANMAST LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 07 feb 2000 Consegnato il 09 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the company and/or padmanor investments limited to the chargee | |
Brevi particolari The property k/a 138/140 old street london EC1 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares membership rights in any management company for the property any goodwill of any business and any other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 07 feb 2000 Consegnato il 09 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become dur from the company and/or padmanor investmnts limited to the chargee | |
Brevi particolari Thye property k/a 28/42 banner street london EC1 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any goodwill of any business and any rental and other money payable under any lease licence. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 nov 1999 Consegnato il 02 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third party legal charge | Creato il 09 feb 1999 Consegnato il 10 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from tristram investments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 138/140 old street london EC1 t/no: NGL673767. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third party legal mortgage | Creato il 09 feb 1999 Consegnato il 10 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from tristram investments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 28/42 banner street london EC1 t/no: NGL673768. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0