BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED

BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03671773
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MORRISON PROPERTY SOLUTIONS (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED05 gen 199905 gen 1999
    CHOQS 317 LIMITED23 nov 199823 nov 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 dic 2010

    Stato del capitale al 09 dic 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    11 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Amministratore
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    TULLY, Robert Charles
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    Amministratore
    29 Balmuir Avenue
    EH48 4BW Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish48389830002
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    Segretario
    Willis Mar,13 Glen Brae
    FK1 5LH Falkirk
    British54477430001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Segretario
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    GRAY, John Colin
    24 Fox Covert
    DY8 3TW Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    24 Fox Covert
    DY8 3TW Stourbridge
    West Midlands
    British1043660002
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Amministratore
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    British1499960006
    JEFFERSON, Andrew Gordon
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    British63406350001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Amministratore
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Amministratore
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Amministratore
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    British73738070001
    MOHAMMED, Ashraf
    7e Highfield Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    7e Highfield Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    British54901250001
    MURRAY, Alan Adams
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish559270001
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    British11456230001
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Amministratore
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Amministratore
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    WALLACE, Lesley Ann
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520003
    WRIGHT, Martin James
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    Well Cottage
    Well House Lane
    RH15 0BN Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish4403900006

    BROADWAY PLAZA (BIRMINGHAM CHILDREN'S HOSPITAL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 ago 2003
    Consegnato il 01 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the f/h and l/h property including land known as the former birmingham's children's hospital and institute of child health,ladywood middleway and francis road edgbaston t/no's WM65763 and WM66221. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Awg Group Limited
    Transazioni
    • 01 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land k/a the former birmingham childrens hospital and institute of child health ladywood middleway and francis road edgbaston t/no. WM657963 and WM662221. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandin Its Capacity as Security Trustee for the Stockholders
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land known as the former birmingham childrens hospital and institute of child health ladywood middleway and francis road edgbaston t/no. WM657963 & wm 662221. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The rental account held by the company with the bank and such new account or accounts as may be opened relative to all rent and other monies due to the company for the benefit of the company under any agreements to lease or any leas and are charged by the charge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of performance bond
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the bank documents
    Brevi particolari
    The whole right title and interest in and to a performace bond dated 19 january 2000 by hermes kreditverscherings ag.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of vat payments
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27 january 2000
    Brevi particolari
    The whole right title and interest in all payments repayments and refunds relating to value added tax and any other amounts due from customs & excise to the company under or pursuant to the value added tax act 1994 or other relevant legislation.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 29 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as broadway plaza lady middleway edgbaston birmingham title numbers WM657963 and WM662221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0