CP PROPCO 2 LIMITED

CP PROPCO 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCP PROPCO 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03679001
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CP PROPCO 2 LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CP PROPCO 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CP PROPCO 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ERMINECARE LIMITED19 apr 199919 apr 1999
    CRIMCARE LIMITED04 dic 199804 dic 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di CP PROPCO 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CP PROPCO 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Churchill Place London E14 5HP a 1 More London Place London SE1 2AF in data 10 lug 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 giu 2019

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 33 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 mag 2019

    • Capitale: GBP 2.00
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 15/05/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    24 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 19

    2 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    23 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 12

    2 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 24

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 14

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 30

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 27

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 28

    1 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 18

    2 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di CP PROPCO 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Segretario
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    GLOGOFF, Marc J
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United StatesAmerican168638450001
    LINDOW, Simon Edwin Guy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish204635960001
    LOGUE, David Andrew
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish188848400001
    SILVERMAN, Robert
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United StatesAmerican204665260001
    ROTH, David John
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    Segretario
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    German154094310001
    THACKRAY, Ellis James
    Melrose Villa Old Church Lane
    Fylingthorpe
    YO22 4TR Whitby
    North Yorkshire
    Segretario
    Melrose Villa Old Church Lane
    Fylingthorpe
    YO22 4TR Whitby
    North Yorkshire
    British20646460001
    BUSINESS ACTION LIMITED
    87 Trippet Lane
    S1 4EL Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    87 Trippet Lane
    S1 4EL Sheffield
    South Yorkshire
    76889650001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BEZIAN, Haig George
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandFrench188848390002
    CALVELEY, Peter, Dr
    Alderley Road
    SK9 1NX Wilmslow
    Emerson Court
    Cheshire
    Amministratore
    Alderley Road
    SK9 1NX Wilmslow
    Emerson Court
    Cheshire
    United KingdomBritish131468590001
    CONWAY, Jonathan Paul
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish160362360002
    LYNAM, Robert Iain
    Beech House
    9 Pendennis Road
    TN13 3JS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Beech House
    9 Pendennis Road
    TN13 3JS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish1374130001
    MCLEAN, Anthony
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    Amministratore
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    United KingdomBritish67231420002
    MITCHELL, Peter
    4 Howard Street
    LN1 1SB Lincoln
    Amministratore
    4 Howard Street
    LN1 1SB Lincoln
    British62080890001
    ROTH, David John
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    Amministratore
    10 Lime Close
    CB5 0JR Burwell
    Cambridgeshire
    EnglandGerman154094310001
    SKULL, Amanda Sarah Osborne
    Steggles Barn
    Whiting Street
    IP33 1NR Bury St Edmunds
    Amministratore
    Steggles Barn
    Whiting Street
    IP33 1NR Bury St Edmunds
    EnglandBritish86782960002
    STOCK, Linda
    Craven Court
    Willie Snaith Road
    CB8 7FA Newmarket
    Tulip House
    Suffolk
    Amministratore
    Craven Court
    Willie Snaith Road
    CB8 7FA Newmarket
    Tulip House
    Suffolk
    United KingdomBritish104973300001
    SULLIVAN, Sean Patrick
    Rustat Avenue
    CB1 3PF Cambridge
    29
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Rustat Avenue
    CB1 3PF Cambridge
    29
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish137653030001
    THACKRAY, Ellis James
    Highfield House
    Bishop Norton Road Glentham
    LN8 2EU Market Rasen
    Lincolnshire
    Amministratore
    Highfield House
    Bishop Norton Road Glentham
    LN8 2EU Market Rasen
    Lincolnshire
    British20646460002
    WELLS, David Habershon
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish140997350001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CP PROPCO 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    06 apr 2016
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5387989
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CP PROPCO 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 27 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 26 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Orton mere 547 oundle road longueville peterborough t/no:CB33645.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a mansfield house 8 first avenue sherwood rise nottingham and 9 second avenue sherwood rise nottinghamt/nos NT16281,NT138266 and NT145876.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a rose lodge langley court underhill street oldbury t/n WM699347.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/ l/h property k/a conifer lodge 134 north brink wisbech t/n CB117709.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H watcombe hall watcombe beach torquay t/n DN198806.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H james house exeter road chudleigh newton abbott t/n DN175843.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ridgeway chapel lane newton wisbech t/n's CB303570 and CB265083.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H ermine lodge high street redbourne gainsborough t/n's HS258880 and HS120412.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H king's delph marex house oilmills road pondersbridge t/n's CB80664 and CB188061.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 lug 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H the cherry tree hungate road emneth wisbech t/n NK173888.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2011
    Consegnato il 25 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H middlestead house 96 draycott road derby t/n DY193314.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Debenture with floating charge
    Creato il 14 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Hurnsfield nursing home barrowby high road grantham t/no LL154453. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    James house exeter road chudleigh newton abbot t/no DN175843. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Orton mere 547 oundle road longueville peterborough t/no CB33645. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mansfield house 8 first avenue sherwood rise nottingham and 9 second avenue sherwood rise nottingham t/nos NT16281, NT138266 and NT145876. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Middlestead house 96 draycott road derby t/no DY193314. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The cherry tree hungate road emneth wisbech t/no NK173888. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ermine lodge high street redbourne gainsborough t/nos HS258880 and HS120412. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Kings' delph marex house oilmills road pondersbridge t/nos CB80664 and CB188061. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Conifer lodge 134 north brink wisbech t/no CB117709. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ridgeway chapel lane newton wisbech t/no. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the security parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rose lodge langley court underhill street oldbury t/no WM699347. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)

    CP PROPCO 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 giu 2019Inizio della liquidazione
    13 ago 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0