ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED

ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03683399
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAILSECOND LIMITED15 dic 199815 dic 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 ott 2015

    • Capitale: GBP 3,930,100
    4 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    17 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 gen 2015

    Stato del capitale al 20 gen 2015

    • Capitale: GBP 2,483,101
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 18

    5 pagineMR05

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 28 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 2,483,101
    SH01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    legacy

    13 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 18 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188567340001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    JAP, Chee Miau
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Segretario
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Singaporean37858790001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    PARK, Sonya C
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    Segretario
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    American75811580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BAILEY JR, Essel William
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    Amministratore
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    American82601840001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Amministratore
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritish38064300002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Amministratore
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    American52843400002
    FRANKE, Thomas Frederick
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    Amministratore
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    United KingdomAmerican50747000001
    GOTTESMAN, Arthur Edward
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    Amministratore
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    American35293490001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    PATEL, Bhikhubhai Maganbhai, Dr
    2 Hornor Close
    NR2 2LY Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    2 Hornor Close
    NR2 2LY Norwich
    Norfolk
    British47040580001
    PATEL, Ketki Bhikhubhai, Dr
    2 Hornor Close
    NR2 2LY Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    2 Hornor Close
    NR2 2LY Norwich
    Norfolk
    British47040650001
    PURT, Trevor George
    Ivy House School Lane
    Lower Heath
    SY13 2BU Whitchurch
    Shropshire
    Amministratore
    Ivy House School Lane
    Lower Heath
    SY13 2BU Whitchurch
    Shropshire
    British19997410001
    QUAYLE, Sylvia Nina
    Ivy House School Lane
    Lower Heath
    SY13 2BU Whitchurch
    Shropshire
    Amministratore
    Ivy House School Lane
    Lower Heath
    SY13 2BU Whitchurch
    Shropshire
    United KingdomBritish19997400001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Amministratore
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    TABERNER, Benjamin Robert
    2 Chatham Grove
    Withington
    M20 1HS Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    2 Chatham Grove
    Withington
    M20 1HS Manchester
    Greater Manchester
    British88809160001
    TABERNER, Benjamin Robert
    2 Chatham Grove
    Withington
    M20 1HS Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    2 Chatham Grove
    Withington
    M20 1HS Manchester
    Greater Manchester
    British88809160001
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    British71527500002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ALLIANCE CARE (WOODSIDE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental security deed
    Creato il 28 mar 2013
    Consegnato il 05 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    T/No CE110696 admiral court, cleveland road, hartlepool l/h by way of first fixed charge all other interests and the benefit of all other agreements relating to the acquired properties.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2012
    Consegnato il 20 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due at any time of any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 nov 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A security deed
    Creato il 30 ott 2006
    Consegnato il 17 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse London Branch
    Transazioni
    • 17 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rhyme debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 14 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 14 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 20 ago 2001
    Consegnato il 24 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 24 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    Including l/h langholm residential care home high bondgate bishop auckland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/H the hollies orchard house evergreens woodlands and bramble court (winlaton care village) garesfield lane winlaton gateshead. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    Including l/h granville 24 granville avenue hartlepool. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    Including l/h the priory nursing home cleveland road hartlepool. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    Including l/h roseberry view and the grange flatts lane nunthorpe middlesborough. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    Including l/h dene hall station road easington colliery county durham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £8,696 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £21,968 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £6,992 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £32,495 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £13,730 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation pursuant to any of the relevant documents (as defined)
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £18,307 paid by the lessee under the deed and all interest earned on the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principal Healthcare Finance Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0