2015 GC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2015 GC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03688345
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2015 GC LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova 2015 GC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2015 GC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORAL GROUP LIMITED26 lug 200226 lug 2002
    CORAL GROUP PLC02 feb 199902 feb 1999
    ACCUMULATOR HOLDINGS NO. 2 PLC18 dic 199818 dic 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2015 GC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 2015 GC LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per 2015 GC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed coral group LIMITED\certificate issued on 06/10/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name06 ott 2015

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 set 2015

    RES15

    Bilancio redatto al 27 set 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mag 2014

    Stato del capitale al 29 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 05 feb 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 dic 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 09/12/2013
    RES13

    Nomina di Harry Willits come amministratore

    2 pagineAP01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    38 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Re-transitional provisions & savings 20/08/2013
    RES13

    Cessazione della carica di Paul Bowtell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 29 set 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Bowtell il 03 ott 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 71 Queensway London W2 4QH England* in data 15 feb 2013

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di 2015 GC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Segretario
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    BOWTELL, Paul
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishExecutive164343080001
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    CLUFF, Peter Charles
    60 Boileau Road
    SW13 9BL Barnes
    London
    Segretario
    60 Boileau Road
    SW13 9BL Barnes
    London
    British65941490001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Segretario
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Segretario
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    BritishDirector17449850001
    WHITEHEAD, Philip Ernest
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    BritishFinance Director48512990001
    ASHDOWN, Vaughn Trevor
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector16667900007
    BEAUMONT, Trevor Kenneth
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishDirector109954570001
    BOWTELL, Paul
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritishExecutive164343080001
    CONNOLLY, Gerard Vincent
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ledbury House Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    IrishChartered Accountant57063820001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    BritishCompany Secretary6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    EnglandBritishDirector151637880001
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritishChief Executive107909600001
    HUGHES, Gary William
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    ScotlandBritishChief Financial Officer151269910001
    MACFIE, Andrew James
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    Amministratore
    9 Corrennie Gardens
    EH10 6DG Edinburgh
    ScotlandBritishInvestment Banker33487610001
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Arrewig Farm
    Arrewig Lane
    HP5 2UA Chartridge
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Arrewig Farm
    Arrewig Lane
    HP5 2UA Chartridge
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector17449850002
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant17449850001
    SCOTT, Robert
    Kentishes Farm
    Stisted
    CM7 8BX Braintree
    Essex
    Amministratore
    Kentishes Farm
    Stisted
    CM7 8BX Braintree
    Essex
    BritishChief Executive63735270002
    WHITEHEAD, Philip Ernest
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director48512990001

    2015 GC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 03 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property being stadium and cromer road and spring garden car parks essex t/n EGL386379. F/h property being lessington avenue/ esher avenue car park essex t/n EGL293249. F/h property being employee house number 1 lessington avenue essex t/n EGL72046. For further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 03 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security accession deed
    Creato il 10 dic 2004
    Consegnato il 21 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 21 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 feb 2004
    Consegnato il 20 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 20 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 17 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for Itself and the Other Secured Parties)(the Security Agent)
    Transazioni
    • 17 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 29 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein and each of the other obligors (as defined) to the secured parties (as defined) (or any of them) under the senior finance documents (as defined) (or any of them) and under the debenture in whatsoever manner
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper,Inc.
    Transazioni
    • 29 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0