AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED

AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03694919
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O EPICOR SOFTWARE (UK) LTD
    No 1 The Arena Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Grove House 1 Grove Place Bedford MK40 3JJ* in data 18 giu 2014

    2 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2014

    Stato del capitale al 11 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2013 al 30 set 2013

    3 pagineAA01

    Nomina di Mr Richard John Clark come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Brims come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 13 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Yu-Ho Cheung il 01 nov 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Mcgovern come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di John David Ireland come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di John Charles Roy Brims come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 13 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    legacy

    24 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHEUNG, Yu-Ho
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    176259100001
    CHEUNG, Yu-Ho, Mr.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    Uk
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    Uk
    EnglandBritish129862370004
    CLARK, Richard John
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91263440001
    IRELAND, John David
    Von Karman Ave
    92612 Irvine
    18101 Suite 1600
    California
    United States
    Amministratore
    Von Karman Ave
    92612 Irvine
    18101 Suite 1600
    California
    United States
    United StatesAmerican129773050001
    FITCHETT, Gail Catherine
    Field Close 2 Ulverscroft Lane
    Newtown Linford
    LE6 0AJ Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    Field Close 2 Ulverscroft Lane
    Newtown Linford
    LE6 0AJ Leicester
    Leicestershire
    British22770290001
    KAISER, Nicholas
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    Segretario
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    United States169823340001
    MAMOS, Gwenydd Patricia
    26 Gladstone Avenue
    LE13 0NG Melton Mowbray
    Leicestershire
    Segretario
    26 Gladstone Avenue
    LE13 0NG Melton Mowbray
    Leicestershire
    British40372670001
    SLORICK, Michael Alexander
    35 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    Segretario
    35 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    British83086860002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARMITAGE, Andrew Victor
    Oakwell House
    Pond Street
    LE12 7NQ Seagrave
    Leicestershire
    Amministratore
    Oakwell House
    Pond Street
    LE12 7NQ Seagrave
    Leicestershire
    British6958440003
    BRIMS, John Charles Roy
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    Uk
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    Uk
    EnglandBritish72118430001
    CARRUTHERS, John Malcolm
    5 Brentingby Close
    LE13 1ES Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Brentingby Close
    LE13 1ES Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish57901870001
    FITCHETT, Kevin
    2 Ulverscroft Lane
    Newtown Linford
    LE6 0AJ Leicester
    Leics
    Amministratore
    2 Ulverscroft Lane
    Newtown Linford
    LE6 0AJ Leicester
    Leics
    EnglandBritish19541910001
    HENNINGS, James M
    613 Calle Reata
    San Clemente Ca
    Orange County 92673
    Usa
    Amministratore
    613 Calle Reata
    San Clemente Ca
    Orange County 92673
    Usa
    American84378830001
    KAISER, Nicholas
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    Amministratore
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    UsaUnited States169823340001
    MCGOVERN, David Michael
    631 14th Street
    Manhattan Street
    California 90266
    United States Of America
    Amministratore
    631 14th Street
    Manhattan Street
    California 90266
    United States Of America
    United States98063980001
    NACHMAN, Peter John
    122 Neptune Avenue
    Hermosa Beach
    California 90254
    Usa
    Amministratore
    122 Neptune Avenue
    Hermosa Beach
    California 90254
    Usa
    American127552800001

    AVALON PRINTING SOFTWARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 26 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties; all bank product obligations; and all obligations of each borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tpg Specialty Lending, Inc.
    Transazioni
    • 26 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • D.B.Zwirn Special Opportunities Fund L.P as Administrative Agent and Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security accession deed
    Creato il 23 gen 2008
    Consegnato il 05 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors and each borrower to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Foothill, Inc. as Administrative Agent and Trustee for the Finance Parties(The Agent)
    Transazioni
    • 05 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    General security agreement
    Creato il 09 feb 2006
    Consegnato il 02 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges all tangible personal property, stock goods, debts, all documents of title, all patents, contractual rights, software, personal property, all undertaking and assets of the company,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Business Development Bank of Canada
    Transazioni
    • 02 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General security agreement
    Creato il 09 feb 2006
    Consegnato il 21 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over all tangible personal property all stock goods and materials all debts monies and choses in action all documents of title securities and instruments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Business Development Bank of Canada
    Transazioni
    • 21 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2002
    Consegnato il 22 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold title at executive house avalon way anstey leicester LE7 7GR. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Victor Armitage
    Transazioni
    • 22 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 1999
    Consegnato il 21 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0