UNILODGE SERVICES LIMITED

UNILODGE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNILODGE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03701321
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNILODGE SERVICES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LITTLESTING LTD26 gen 199926 gen 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 feb 2015

    Stato del capitale al 19 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2014

    Stato del capitale al 10 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di UNILODGE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Segretario
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    British175753180001
    ALLAN, Mark Christopher
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Amministratore
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    EnglandBritish74371010007
    FFORDE, Arthur William Brownlow
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    Segretario
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    British9233240002
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Segretario
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    British67884910002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BERNSTEIN, Simon Laurence
    54 Clifton Hill
    NW8 0QG London
    Amministratore
    54 Clifton Hill
    NW8 0QG London
    United KingdomBritish76033770001
    FFORDE, Arthur William Brownlow
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    Amministratore
    9 Catherine Place
    SW1E 6DX London
    British9233240002
    FFORDE, Edward James Alexander
    Holland House
    Little London, Albury
    GU5 9DG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Holland House
    Little London, Albury
    GU5 9DG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish14297400004
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    Amministratore
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    British45656280001
    PORTER, Nicholas Anthony
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    Amministratore
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    British45837900004
    RANSOME, David Peter
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritish67258390002
    CS SCF MANAGEMENT LIMITED
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    83374930001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    UNILODGE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of rents
    Creato il 28 giu 2001
    Consegnato il 18 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from unite group PLC (the "borrower") to each finance party (as defined) under each of the finance documents 9AS defined) in any currency whatsoever
    Brevi particolari
    The subjects at sandyford st,glasgow; gla 9263 (35 sandyford street),gla 18149 (30-52 eastvale place),gla 142501 (0.07 acres at eastvale place) and gla 143129 (part of 2/28 eastvale place,gla 54607) and the subjects at tay works,19,21 and 23 brown st,dundee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC,as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 18 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party debenture
    Creato il 28 giu 2001
    Consegnato il 05 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All of the company's obligations and liabilities due or to become due from the unite group PLC to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as defined) under each of the finance documents (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 20 lug 1999
    Consegnato il 09 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a lease over the premises known as tay works,brown street/guthrie street,dundee
    Brevi particolari
    All right and interest to receive all rent,licence fees,premiums and other payments under the leases listed in the schedule and known as phase ii or 21 brown st,dundee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unilodge Property Limited
    Transazioni
    • 09 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over accounts
    Creato il 20 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the lease of even date
    Brevi particolari
    The security assets for payment of the secured liabilities and all rights,title and interests in the deposit and the account (as DEFINED0. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unilodge Property Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0