HMV INVESTMENTS LIMITED

HMV INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHMV INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03702249
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HMV INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova HMV INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HMV INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HMV MEDIA INVESTMENTS LIMITED19 mar 199919 mar 1999
    WASTETOTAL LIMITED27 gen 199927 gen 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di HMV INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HMV INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Ian Peter Kenyon come amministratore in data 31 gen 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Philip Moore come amministratore in data 08 feb 2013

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elaine Marriner come amministratore in data 24 gen 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elaine Marriner come segretario in data 24 gen 2013

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ian Peter Kenyon come amministratore in data 03 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Trevor Philip Moore come amministratore in data 03 set 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Richard Fox come amministratore in data 03 set 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 apr 2012

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Shelley House 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR in data 13 mar 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2012

    Stato del capitale al 27 gen 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neil Bright come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 apr 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Elaine Marriner il 16 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Richard Fox il 16 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Elaine Marriner il 16 feb 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Neil Irvine Bright il 16 feb 2010

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Conto per una società dormiente redatto al 25 apr 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di HMV INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUTT, Annette Hoi
    1st Floor 66 Princes Square
    W2 4NY London
    Segretario
    1st Floor 66 Princes Square
    W2 4NY London
    British63097100001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Segretario
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Segretario
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Segretario
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House
    2-4 York Road
    SL6 1SR Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Shelley House
    2-4 York Road
    SL6 1SR Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish180993450001
    BUTT, Annette Hoi
    1st Floor 66 Princes Square
    W2 4NY London
    Amministratore
    1st Floor 66 Princes Square
    W2 4NY London
    British63097100001
    EDGE, Andrew John
    21c Alderbrook Road
    SW12 8AF London
    Amministratore
    21c Alderbrook Road
    SW12 8AF London
    British66573870002
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Amministratore
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Amministratore
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Amministratore
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HMV INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A second priority right of pledge
    Creato il 16 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including the parallel debt referred to below) under or pursuant to the pledge as the same may be extended, prolonged, amended, renewed or novated from time to time and all obligations of the parent to the chargee under the finance documents (as defined) and/or pursuant to the deed of pledge of shares dated 28TH march 1998 (including the parallel debt contained and defined therein)
    Brevi particolari
    All of the present shares and all cash dividends paid or payable at any time after the date of the pledge on all or any of the present shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Emi Group PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1999
    Consegnato il 12 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and including the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transazioni
    • 12 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1999
    Consegnato il 15 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior facility agreement (as defined) and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag,as Security Agent in Accordance with the Senior Facility Agreement (As Defined)
    Transazioni
    • 15 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 1999
    Consegnato il 15 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee for the Holders (As Defined) and in Accordancewith the Senior Facility Agreement (as Defined)
    Transazioni
    • 15 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0