GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED

GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03702378
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WILKINS KENNEDY
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROCKMARTIN NWP LIMITED01 feb 199901 feb 1999
    WINGVIEW PROPERTIES LIMITED27 gen 199927 gen 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2015

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2014

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2013

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2012

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2011

    11 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY* in data 26 ago 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Alistair Guy Smee come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Silvester come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2010

    Stato del capitale al 04 feb 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY United Kingdom

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY Uk* in data 03 feb 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Peter Silvester il 02 feb 2010

    2 pagineCH01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, William Quentin
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishExecutive28918420001
    SMEE, Alistair Guy
    Crazies Hill
    Wargrave
    RG10 8LY Reading
    Pear Tree Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Crazies Hill
    Wargrave
    RG10 8LY Reading
    Pear Tree Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishChartered Surveyor126179690002
    SMEE, Roger Guy, Mr.
    Crazies Hall
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Crazies Hall
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomUnited KingdomSurveyor29088830008
    SILVESTER, Robert Peter
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    Segretario
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    BritishSurveyor101631490001
    SUGAR, Steven Charles
    13 Wilkinson Street
    SW8 London
    Segretario
    13 Wilkinson Street
    SW8 London
    BritishSolicitor42606930001
    FORSTERS SECRETARIES LIMITED
    67 Grosvenor Street
    W1K 3JN London
    Segretario
    67 Grosvenor Street
    W1K 3JN London
    60863750002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    EADIE, Craig Farquhar
    9 Denmark Road
    SW19 4PG London
    Amministratore
    9 Denmark Road
    SW19 4PG London
    BritishSolicitor20083410001
    GREENWOOD, Patrick John Aberneithy
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    BritishBusinessman Company Director77514730001
    HUNTLEY, Andrew John Mack
    Ashurst
    Fernhurst
    GU27 3JB Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Ashurst
    Fernhurst
    GU27 3JB Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor2995330001
    SILVESTER, Robert Peter
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    Amministratore
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    BritishSurveyor101631490001
    SILVESTER, Robert Peter, Mr.
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    Amministratore
    15 Knowsley Way
    TN11 9LG Hildenborough
    Kent
    United KingdomUnited KingdomChartered Surveyor101631490002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over rent and general accounts
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All it's right, title and interest in the charged balance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over deposit account
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All it's right in the charged balance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over rental account
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the charged balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of rental assignment
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in all rent of the properties known as 34/35 market place 2-16 peach street and 1-4 the arcade wokingham t/n BK62437,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture (floating charge)
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge all property and assets present and future from time to time owned by the company or in which the company may have an interest.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as 34/35 market place wokingham 2-16 peach street and 1-4 the arcade wokingham t/n BK62437,. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge supplemental to a loan agreement dated 30 june 1999
    Creato il 18 apr 2000
    Consegnato il 27 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £827,923 and any other liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement and this charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h,l/h or immovable property as land and buildings on the north side of market place and on the north west side of peach street,wokingham,berkshire.t/no.BK62437 and any part or parts of it and including all rights attached to it and all buildings,fixtures,fittings,plant and machinery from time to time situate on it and belonging to the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ashfern Developments Limited
    • Rock Investment Trust PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 03 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent for the associated companies (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2004Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 10 lug 2004Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
      • Numero di pratica 1

    GLANCEPRESS (WOKINGHAM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 giu 1999Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Praticante
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Sarah Symons
    27 Soho Square
    London
    W1V 6AX
    Praticante
    27 Soho Square
    London
    W1V 6AX
    2
    DataTipo
    23 ago 2010Inizio della liquidazione
    27 ago 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Arthur Kirkpatrick
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Praticante
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Keith Aleric Stevens
    Wilkins Kennedy
    Gladstone House
    TW20 9HY 77/79 High Street
    Egham
    Praticante
    Wilkins Kennedy
    Gladstone House
    TW20 9HY 77/79 High Street
    Egham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0