TNR COMMUNICATIONS LIMITED

TNR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTNR COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03704364
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Attività di produzione di programmi televisivi (59113) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TELEVISION NEWS RELEASE LIMITED29 gen 199929 gen 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 mag 2013

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 29 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2013

    Stato del capitale al 27 mar 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Steven Brown il 23 feb 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Claire Southeard come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven Brown come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Susanna Ross come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Clive Paul Marshall come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 29 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Campbell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy William Kerr il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Amanda Jane Richards il 30 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Timothy William Kerr come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TNR COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Steven John
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Segretario
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    159526640001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director Chartered Ac3379480001
    KERR, Timothy William
    Holmewood Road
    SW2 3RR London
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Holmewood Road
    SW2 3RR London
    24
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Photography147995740002
    MARSHALL, Clive Paul
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Amministratore
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    EnglandBritishChief Executive, Pa Group148973430001
    RICHARDS, Amanda Jane
    Elsenham Street
    SW18 5NY London
    111
    United Kingdom
    Amministratore
    Elsenham Street
    SW18 5NY London
    111
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Production & Operations133461500003
    DOCKRAY, Dawn Tracy
    12 Park Lane
    Burn
    YO8 8LW Selby
    North Yorkshire
    Segretario
    12 Park Lane
    Burn
    YO8 8LW Selby
    North Yorkshire
    British35663000002
    MAJORIBANKS, Richard John Bradley
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary83362640001
    ROSS, Susanna Helena
    Tudor Close
    NW3 4AG London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Tudor Close
    NW3 4AG London
    25
    United Kingdom
    Other129565780001
    WALLACE, David Adair
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    Segretario
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    EnglishManagement Consultant39911770003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BOYNTON, Simon Stuart
    Harlequin Lane
    TN6 1HU Crowborough
    Lavander Lodge
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Harlequin Lane
    TN6 1HU Crowborough
    Lavander Lodge
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director, Pa Business129575320001
    CAMPBELL, David Ian
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishEditor104602970001
    CURTIS-WARD, Sean Anthony Bernard
    35 King Edwards Gardens
    W3 9RF London
    Amministratore
    35 King Edwards Gardens
    W3 9RF London
    EnglandBritishTelevision Producer19391430002
    GARDNER, Stephen
    Sparrows Cottage
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sparrows Cottage
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishJournalist83971540001
    SOUTHEARD, Claire Helen
    Flat 4
    71 West Hill
    SW15 2UL London
    Amministratore
    Flat 4
    71 West Hill
    SW15 2UL London
    United KingdomBritishManaging Director99610640003
    TEUNON, Nicholas John
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    Amministratore
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    BritishAccountant80035420001
    WALLACE, David Adair
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    Amministratore
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    EnglandEnglishDirector39911770003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TNR COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 ott 2008
    Consegnato il 29 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 27 ott 2008
    Consegnato il 29 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2002
    Consegnato il 09 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Pa News Limited
    Transazioni
    • 09 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mar 2000
    Consegnato il 28 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TNR COMMUNICATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 apr 2014Data di scioglimento
    01 mag 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0