GREENVALE FOODS LIMITED

GREENVALE FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREENVALE FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03705030
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREENVALE FOODS LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di patate (10310) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova GREENVALE FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Greenvale Ap Floods Ferry Road
    Doddington
    PE15 0UW March
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREENVALE FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOWPER 259 LIMITED29 gen 199929 gen 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREENVALE FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per GREENVALE FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2012

    Stato del capitale al 23 nov 2012

    • Capitale: GBP 12,428,572
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 25 giu 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 26 giu 2010

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facilities agreement 11/11/2010
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Anthony Bambridge come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 27 giu 2009

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 28 giu 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di GREENVALE FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACDONALD, George Brian
    Oldhamstocks
    TD13 5YN Cockburnspath
    Ferneylea
    Berwickshire
    Segretario
    Oldhamstocks
    TD13 5YN Cockburnspath
    Ferneylea
    Berwickshire
    British136404540001
    DAVIES, Edward Lance
    Field House
    Ford Heath
    SY5 9GG Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Field House
    Ford Heath
    SY5 9GG Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish5847230004
    MACDONALD, George Brian
    Oldhamstocks
    TD13 5YN Cockburnspath
    Ferneylea
    Berwickshire
    Amministratore
    Oldhamstocks
    TD13 5YN Cockburnspath
    Ferneylea
    Berwickshire
    United KingdomBritish136404540001
    RANSLEY, Brandon William
    The Granary Tunnel Hill Mews
    Knock Lane Blisworth
    NN7 3DA Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    The Granary Tunnel Hill Mews
    Knock Lane Blisworth
    NN7 3DA Northampton
    Northamptonshire
    British61675530002
    HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Segretario
    Oxford House
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    67683490001
    ASBURY, Robin Christopher
    Achnacille
    Kilmelford
    PA34 4XD Oban
    Argyll
    Amministratore
    Achnacille
    Kilmelford
    PA34 4XD Oban
    Argyll
    ScotlandBritish116042010001
    BAMBRIDGE, Anthony William James
    Park Farm
    Moorgate Blickling
    NR11 6PU Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Park Farm
    Moorgate Blickling
    NR11 6PU Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish62315070001
    BEHAGG, Andrew
    138 London Road
    PE16 6SG Chatteris
    Cambridgeshire
    Amministratore
    138 London Road
    PE16 6SG Chatteris
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish48517660001
    OWENS, Alan Henry
    The Vines
    13 Severn Bank
    SY1 2JD Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    The Vines
    13 Severn Bank
    SY1 2JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish49641080001
    SMITH, Stuart Peter John, Doctor
    Loddon House Beccles Road
    Loddon
    NR14 6JQ Norfolk
    Amministratore
    Loddon House Beccles Road
    Loddon
    NR14 6JQ Norfolk
    British60195140001
    HP DIRECTORS LIMITED
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Oxford House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Cliftonville
    NN1 5PN Northampton
    Oxford House
    Northamptonshire
    48175890001

    GREENVALE FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 13 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 07 apr 2006
    Consegnato il 12 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 12 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 15 ott 2002
    Consegnato il 30 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 15 ott 2002
    Consegnato il 24 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 15 ago 2002
    Consegnato il 29 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 08 feb 2000
    Consegnato il 11 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company the chargees on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The pleant and equipment supplier john smart & associates, invoice number/reference GV3 invoice date 18 january 2000, supplier s & j (chatteris) construction limited, invoice number/reference 022027, invoice date 3 january 200, in each case including all accessories, ancillary equipment and additions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Leasing LTD
    • Royscot Commercial Leasing LTD
    • Royscot Industrial Leasing LTD
    • Royscot Spa Leasing LTD
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 25 nov 1999
    Consegnato il 30 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The equipment described in the schedule attached to the form 395 and the proceeds and products thereof and benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC Royscot Leasing LTD Royscot Industrial Leasing LTD Royscot Commercialleasing LTD & Royscot Spa Leasing LTD
    Transazioni
    • 30 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 15 nov 1999
    Consegnato il 02 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at boleness road wisbech cambridgeshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creato il 15 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land at boleness road, wisbech, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ott 1999
    Consegnato il 02 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0