PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03710618 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Chickenhall Lane Eastleigh SO50 6YU Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PIRELLI CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED | 02 ott 2000 | 02 ott 2000 |
| BICC GENERAL INDUSTRIAL CABLES LIMITED | 13 mag 1999 | 13 mag 1999 |
| VIEWTRADE LIMITED | 10 feb 1999 | 10 feb 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Luca Caserta come amministratore in data 01 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Colin Anthony Briggs come segretario in data 01 ott 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Stephen Farrell come segretario in data 01 ott 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alberto Maffioli come amministratore in data 01 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 27 set 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 29 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Paul Raymond Atkinson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Massimo Battaini come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip Brown come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGGS, Colin Anthony | Segretario | Chickenhall Lane Eastleigh SO50 6YU Hampshire | 191679080001 | |||||||
| ATKINSON, Paul Raymond | Amministratore | Holly Meadows Stockbridge Road SO22 5FQ Winchester 4 Hampshire | United Kingdom | Australian | 156849990001 | |||||
| CASERTA, Luca | Amministratore | Chickenhall Lane Eastleigh SO50 6YU Hampshire | United Kingdom | Italian | 191626950001 | |||||
| FARRELL, Peter Stephen | Segretario | 37 Ramillies Avenue Cheadle Hulme SK8 7AQ Stockport Cheshire | British | 64332060001 | ||||||
| FARRELL, Peter Stephen | Segretario | 37 Ramillies Avenue Cheadle Hulme SK8 7AQ Stockport Cheshire | British | 64332060001 | ||||||
| PIPER, David John | Segretario | Cherry Tree Cottage Highmoor RG9 5DH Henley On Thames Oxfordshire | British | 8673860001 | ||||||
| SODERBERG, John Warren | Segretario | 36 Netherhall Gardens Flat 3 Hampstead NW3 5TP London | American | 76253090002 | ||||||
| TONKS, Sarah Uny | Segretario | 75 Riverview Grove Chiswick W4 3QP London | British | 50527990003 | ||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Segretario nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||
| BATTAINI, Massimo | Amministratore | 4 Holly Meadow Stockbridge Road SO22 5FQ Winchester Hampshire | Italian | 105007750002 | ||||||
| BROWN, Philip Crabtree | Amministratore | Oak Apples Eastworth Road BH31 7PJ Verwood Dorset | British | 93874250001 | ||||||
| COFFEY, Martyn | Amministratore | 4 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | 105811920001 | ||||||
| COX, Andrew Edward | Amministratore | 4 Larkhill Lane Formby L37 1LX Liverpool Merseyside | British | 31638930001 | ||||||
| DOWNIE, Michael James | Amministratore | 21 Leycester Road WA16 8QR Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 95098980001 | |||||
| HANNIDES, George Michael | Amministratore | 7 Great North Rd Brookmans Park AL96AB Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 127571820001 | |||||
| LEONI, Stefano | Amministratore | 34 Newitt Place Bassett SO16 7FA Southampton Hampshire | Italian | 109017230002 | ||||||
| MAFFIOLI, Alberto | Amministratore | Newitt Place Bassett SO16 7FA Southampton 34 Hampshire | United Kingdom | Italian | 136869770001 | |||||
| MARGRAVE, Philip John | Amministratore | 9 Marquis Way Aldwick PO21 4AT Bognor Regis West Sussex | England | British | 51493580001 | |||||
| MARTINO, Ezio | Amministratore | Via Tiziano 46 FOREIGN Torino 10126 Italy | Italian | 64339000001 | ||||||
| MATTIUZZO, Mauro | Amministratore | 125 Home Park Road Wimbledon SW19 7HT London | Italian | 101638560001 | ||||||
| PIPER, David John | Amministratore | Cherry Tree Cottage Highmoor RG9 5DH Henley On Thames Oxfordshire | British | 8673860001 | ||||||
| SCOTT, Peter | Amministratore | 16 Graburn Road L37 3PB Liverpool Merseyside | British | 64331860001 | ||||||
| SIVERD, Robert Joseph | Amministratore | 8051 Brill Road Cincinnati Oh 45243 Ohio Usa | American | 64331710001 | ||||||
| SODERBERG, John Warren | Amministratore | 36 Netherhall Gardens Flat 3 Hampstead NW3 5TP London | United Kingdom | American | 76253090002 | |||||
| TAGLIAPIETRA, Marco, Dr | Amministratore | 1 Holly Meadows SO22 5FQ Winchester Hampshire | Italian | 85621020002 | ||||||
| TONKS, Sarah Uny | Amministratore | 75 Riverview Grove Chiswick W4 3QP London | British | 50527990003 | ||||||
| VIRGULAK, Christopher Francis | Amministratore | 8124 Starting Gate Lane FOREIGN Cincinnati Oh 45249 Ohio Usa | American | 64331780002 | ||||||
| NOROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
PRYSMIAN CABLES (INDUSTRIAL) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 14 dic 2005 Consegnato il 22 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An accession deed to a debenture dated 28 july 2005 | Creato il 28 lug 2005 Consegnato il 08 ago 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0