SECAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSECAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03711104
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SECAL LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SECAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SECAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SECAL LASER LTD06 apr 200106 apr 2001
    SECAL MARKETING LTD10 feb 199910 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di SECAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SECAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    30 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit C1-C4 Halesfield 5 Telford Shropshire TF7 4QJ a Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE in data 10 set 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    59 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Jonathan Lindon Collins come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Lindon Collins il 12 dic 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 dic 2017

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Darren Jackson Shimmons come amministratore in data 21 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 037111040008, creata il 08 nov 2017

    23 pagineMR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 dic 2016

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roger Lee Lavender il 15 ott 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 dic 2015

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2016

    Stato del capitale al 24 feb 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    21 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed secal laser LTD\certificate issued on 30/09/15
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 29 set 2015

    RES15

    Chi sono gli amministratori di SECAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRIFFITHS, Angela Joan
    Patricia Drive
    SY2 5YU Shrewsbury
    12
    England
    Segretario
    Patricia Drive
    SY2 5YU Shrewsbury
    12
    England
    British61113510002
    LAVENDER, Roger Lee
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Amministratore
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    United KingdomBritish74814380007
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    CLAYTON, Glanville Vaughan
    Stone Drive
    TF11 9LX Shifnal
    9
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Stone Drive
    TF11 9LX Shifnal
    9
    Shropshire
    England
    EnglandBritish109892850003
    CLAYTON, Glanville Vaughan
    3 Newport Crescent
    TF11 8BS Shifnal
    Salop
    Amministratore
    3 Newport Crescent
    TF11 8BS Shifnal
    Salop
    EnglandBritish109892850001
    COLLINS, Jonathan Lindon
    Unit C1-C4
    Halesfield 5
    TF7 4QJ Telford
    Shropshire
    Amministratore
    Unit C1-C4
    Halesfield 5
    TF7 4QJ Telford
    Shropshire
    United KingdomBritish135540690003
    GREEN, Michael
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish9581830001
    MACKENZIE, Allan
    54 Smallwood
    Sutton Hill
    TF7 4HL Telford
    Salop
    Amministratore
    54 Smallwood
    Sutton Hill
    TF7 4HL Telford
    Salop
    British62891140001
    MILLS, Stephen Muarice
    34 Longmeadow Drive
    DY3 3QH Dudley
    West Midlands
    Amministratore
    34 Longmeadow Drive
    DY3 3QH Dudley
    West Midlands
    British80576550001
    SHIMMONS, Darren Jackson
    Station Road
    Albrighton
    WV7 3DP Wolverhampton
    79
    England
    Amministratore
    Station Road
    Albrighton
    WV7 3DP Wolverhampton
    79
    England
    United KingdomBritish159370670002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SECAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Rjt Enterprise
    Halesfield 5
    TF7 4QJ Telford
    Unit C1-4
    England
    01 gen 2017
    Halesfield 5
    TF7 4QJ Telford
    Unit C1-4
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglands
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione06104584
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SECAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 nov 2017
    Consegnato il 09 nov 2017
    In corso
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2014
    Consegnato il 16 apr 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Assignment.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 16 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal assignment
    Creato il 23 mar 2011
    Consegnato il 25 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 28 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (“the Security Holder”)
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 28 gen 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all factored receivables which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (“the Security Holder”)
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2002
    Consegnato il 08 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts
    Creato il 29 mag 2001
    Consegnato il 08 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (being the invoice discounting agreement made between the company and the chargee for the purchase of debts and their related rights) or otherwise; and duly perform all the obligations other than monetary liabilities
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all purchased debts (being any debt as defined in the agreement together with related rights) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and the proceeds thereof and the other debts, floating charge such of the monies which the company may receive in respect of the other debts as shall for the time being stand released from the fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SECAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 ago 2019Inizio dell'amministrazione
    28 apr 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praticante
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Anthony Steven Barrell
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0