CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03712018
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    • (6603) /

    Dove si trova CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yorkshire House
    18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CBS INSURANCE HOLDINGS PLC24 mar 199924 mar 1999
    FORECASTWIN PUBLIC LIMITED COMPANY11 feb 199911 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 feb 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 feb 2012

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place London E1 6NN in data 21 feb 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2010

    32 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    18 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2011

    Stato del capitale al 03 mar 2011

    • Capitale: GBP 4,593.86
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2009

    36 pagineAA

    Stato del capitale al 18 ago 2010

    • Capitale: GBP 4,559.3855
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem 14/07/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 02 feb 2010. L'elenco degli azionisti è stato modificato

    22 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    22 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2008

    35 pagineAA

    legacy

    13 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-MDSC

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 17/12/2008
    RES13

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    48 pagineMAR

    Chi sono gli amministratori di CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Amministratore
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Segretario
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    Amministratore
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    FABER, Robin Henry Grey
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    Amministratore
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    EnglandBritish104985010001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Amministratore
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Amministratore
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MCCLEAN, Michael Hugh Patrick
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    Amministratore
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    British57912890001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Amministratore
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Amministratore
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 ott 2004
    Consegnato il 25 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share charge
    Creato il 11 ott 2004
    Consegnato il 25 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 ott 2004
    Consegnato il 25 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Floating charge
    Creato il 21 feb 2002
    Consegnato il 07 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871
    Transazioni
    • 07 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 16 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 26 nov 1999
    Consegnato il 03 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 mar 2013Data di scioglimento
    15 feb 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul J Fleming
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Praticante
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0