MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED
Panoramica
Nome della società | MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
Numero di società | 03714658 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | No |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Servizi di supporto all'istruzione (85600) / Istruzione
Dove si trova MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 16 feb 2026 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 02 mar 2026 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 16 feb 2025 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2024 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 13 pagine | AA | ||
Nomina di Amelia Jane Margaret Barker come amministratore in data 23 ott 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Simon Joseph Hague come amministratore in data 23 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2022 | 17 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Simon Joseph Hague come amministratore in data 29 set 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Eoin Christopher Damien Keogh come amministratore in data 05 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Eoin Christopher Damien Keogh come amministratore in data 03 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Stephanie Jane Goad come amministratore in data 25 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2021 | 17 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 16 pagine | AA | ||
Nomina di Ms Louise Rosina Humphrey come segretario in data 28 set 2020 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Ashley Mark Hook come amministratore in data 03 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Anne Gaylor Barton come amministratore in data 03 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Geoffrey Malcolm Waters come amministratore in data 03 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Tamara Karolyn Holmes Robertson come amministratore in data 03 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 20 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 21 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMPHREY, Louise Rosina | Segretario | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | 275219500001 | |||||||
BARKER, Amelia Jane Margaret | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Director Of Customer And Transformation | 315080460001 | ||||
HOOK, Ashley Mark | Amministratore | Chatham Maritime ME4 4LL Chatham Broadside England | England | British | Chief Executive | 90583010002 | ||||
BIRTON, Terence James | Segretario | 12 Northwood Avenue High Halstow ME3 8SX Rochester Kent | British | Director Secretary | 115168450001 | |||||
BURTON, Terence James | Segretario | 12 Northwood Avenue High Halstow ME3 8SX Rochester Kent | British | 40230380001 | ||||||
BURTON, Terence James | Segretario | 12 Northwood Avenue High Halstow ME3 8SX Rochester Kent | British | 40230380001 | ||||||
CAMPBELL WROE, William Andrew | Segretario | 21 Belgrave Road ME12 3EB Sheerness Kent | British | 102438970001 | ||||||
DEWEY, Carl Edward | Segretario | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | 150866380001 | |||||||
GRANT, Estelle Marie | Segretario | 9 Farrier Close Weavering ME14 5SR Maidstone Kent | British | Initiatives Manager | 94910350001 | |||||
JACKSON, Katy | Segretario | Dux Court Barn Dux Court Road ME3 8RZ Rochester Kent | British | 109481330001 | ||||||
JAMES, Lucy Victoria | Segretario | Flat 53 Edgson House Ebury Bridge Road SW1W 8RU London | British | Trainee Solicitor | 62298430001 | |||||
POCOCK, Isabelle | Segretario | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | 184825330001 | |||||||
ARMSON, John Moss, Canon | Amministratore | Easter Garth Kings Orchard ME1 1SX Rochester Kent | British | Cathedral Canon | 34120410001 | |||||
BAKER, Edward Winton, Councillor | Amministratore | 11 Watts Avenue ME1 1RX Rochester Kent | United Kingdom | British | Retired | 90192220001 | ||||
BARTON, Elizabeth Anne Gaylor | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Solicitor | 184825570001 | ||||
BURTON, Terence James | Amministratore | 12 Northwood Avenue High Halstow ME3 8SX Rochester Kent | United Kingdom | British | Director And Secretary | 40230380001 | ||||
CLARK, Gary | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | United Kingdom | British | Operations Director | 172966510001 | ||||
CLUMPUS, Lynne | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Director | 152270350001 | ||||
COOPER, Patricia Elsie, Councillor | Amministratore | 28 Dial Road ME7 2RL Gillingham Kent | British | Local Councillor | 66138260001 | |||||
GOAD, Stephanie Jane | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Operations Director | 180880720001 | ||||
GOULDEN, Anthony Ronald | Amministratore | 37 Raleigh Close ME5 7SB Chatham Kent | United Kingdom | British | Avionics Technician | 86377620001 | ||||
GULVIN, Patricia Ann | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Councillor | 180786650001 | ||||
HAGUE, Simon Joseph | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Director | 266029940001 | ||||
HAYES, Sarah Elizabeth | Amministratore | 75 Somerset Road EN5 1JD New Barnet Hertfordshire | British | Solicitor | 74227670001 | |||||
HIGH, Desmond Charles Fitzpatrick | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Certified Chartered Accountant | 29263250002 | ||||
HILL, Roger John | Amministratore | 64 Priestfields ME1 3AB Rochester Kent | British | Chief Executive | 66138170001 | |||||
HOOK, Ashley Mark | Amministratore | 66 Rochester Avenue BR1 3DW Bromley Kent | England | British | Housing Director | 90583010002 | ||||
HULL, Catherine Jane | Amministratore | Broadside Leviathan Way ME4 4LL Chatham Kent | England | British | Director | 80238370001 | ||||
JAMES, Lucy Victoria | Amministratore | Flat 53 Edgson House Ebury Bridge Road SW1W 8RU London | British | Trainee Solicitor | 62298430001 | |||||
JOHNSTONE, Archibald Mackinnon | Amministratore | 81a High Street ME1 1LX Rochester Kent | England | British | Tool Merchant | 15977460002 | ||||
KENWARD, Eileen Beatrice | Amministratore | 27 Hollywood Lane Wainscott ME3 8AG Rochester Kent | United Kingdom | British | Retired | 83844040002 | ||||
KEOGH, Eoin Christopher Damien | Amministratore | Leviathan Way ME4 4LL Chatham Broadside Kent England | England | Irish | Company Director | 168883240001 | ||||
KERSTING-WOODS, Alexa Georgina | Amministratore | 15 Cheriton Way ME16 0PH Maidstone Kent | British | Fundraiser | 71086240001 | |||||
KERSTING-WOODS, Alexa Georgina | Amministratore | 28 Kingfisher Meadow Hart Street ME16 8RB Maidstone Kent | British | Fire Incident Control Officer | 71086240004 | |||||
KITSON, Arthur George | Amministratore | 73 Old London Road TN35 5NB Hastings East Sussex | England | British | Management Consultant | 66638900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mhs Homes Limited | 03 apr 2017 | Chatham Maritime ME4 4LL Chatham Broadside England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MHS COMMUNITY CHARITY LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
16 feb 2017 | 03 apr 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0