WATERS RETAIL LIMITED

WATERS RETAIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATERS RETAIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03716100
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WATERS RETAIL LIMITED?

    • (5010) /
    • (5020) /
    • (5030) /

    Dove si trova WATERS RETAIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ZOLFO COOPER
    The Zenith Building
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WATERS RETAIL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    W WATERS & SONS LTD10 mar 199910 mar 1999
    WATERS (1896) LIMITED19 feb 199919 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATERS RETAIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per WATERS RETAIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagine4.72

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 ott 2012

    14 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 apr 2012

    13 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    32 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da Waters Retail Lyon Way St Albans Hertfordshire AL4 0LQ in data 12 ott 2011

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2011

    Stato del capitale al 29 mar 2011

    • Capitale: GBP 4,800,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Robert Hannah il 19 feb 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Darren Payne come amministratore

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Nomina di Mark Frank Jenkins come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Mr John Robert Hannah il 19 feb 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    Chi sono gli amministratori di WATERS RETAIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANNAH, John Robert
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Segretario
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    British138883780001
    HANNAH, John Robert
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Amministratore
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    United KingdomBritish138883780001
    JENKINS, Mark Frank
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Amministratore
    c/o Zolfo Cooper
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    UkBritish93204480001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    British141282680001
    VARNEY, Peter Reginald
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Segretario
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British68629570001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COMBER, David Cyril
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    British60898610001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    British141282680001
    HESLOP, David Christopher
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritish18365540002
    ISHIKAWA, Masashi
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    Japanese74123760005
    KATANO, Tomio
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    Amministratore
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    Japanese103307300002
    MURAI, Kenji
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    Amministratore
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    Japanese117074780002
    OFSTEDAHL, Darryl Bryan
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    Canadian60898890001
    PAYNE, Darren
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish138883790002
    SHIBATA, Ichiro
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    British103307260001
    VARNEY, Peter Reginald
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Amministratore
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British68629570001
    VILTON, John Philip
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    British17532180003

    WATERS RETAIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    General charge
    Creato il 08 lug 2010
    Consegnato il 13 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's assets of whatsoever nature wheresoever both situated both present and future including uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Bank Gmbh Trading as Volkswagen Bank United Kingdom Branch
    Transazioni
    • 13 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 21 lug 2009
    Consegnato il 29 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re waters retail limited business premium account, account number 43403173.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge on new and used motor vehicles
    Creato il 17 nov 2006
    Consegnato il 21 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all such of the present and future property and assets of the borrower,all new and used mazda motor vehicles that are funded and/or supplied by fce,first fixed charge all proceeds of sale or other dispostion of any of the motor vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fce Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 05 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage land and premises at 802-808 green lanes, winchmore hill, enfield, london N21 2SA, title numbers EGL333448 and EGL313673 and all buildings, fixed plant and machinery thereon and all rights, easements and privileges relating thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 05 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 27 lug 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The deposit account referred to in the deed and all money withdrawn from it pursuant to the deed (the initial amount deposited is £12,000).
    Persone aventi diritto
    • Vittoria Nina Cox
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 apr 1999
    Consegnato il 27 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at aero garage,comet way,hatfield; t/no HD347108; all buildings,fixtures,fixed plant/machinery thereon with all rights,easements/privileges thereto; the benefit of all contracts/warranties thereto and all moneys from time to time payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at west herts toyota,water end,hemel hempstead; t/no hd 246151; all buildings,fixed plant machinery and fixtures thereon with all related rights thereto; the benefit of all contracts/warranties and all moneys payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at 58-60 st andrew street,hertford; t/no hd 206810; all buildings,fixtures,plant/machinery thereon together with all related rights thereto; the benefit of all contracts/warranties and all moneys payable under any contracts/policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at waters garage,3/9 north rd,hertford; t/no HD207906 with all buildings,fixtures,plant/machinery thereon and all rights thereto; the benefit of all contracts and warranties and all moneys payable under any contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at 29 burrowfield welwyn garden city; t/no hd 158149; all buildings,fixtures,plant,machinery thereon and all rights thereto; benefit of all contracts and all moneys payable from time to time under any contracts or policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at coachfields,fiddle bridge lane,hatfield; t/no HD316382; all buildings,fixtures,plant/machinery thereon and all rights,easements,benefit of all contracts/warranties thereto; all moneys payable from time to time under any contracts or policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land/blds at 12 harpsfield broadway,comet way,hatfield; t/no HD13725; all buildings,fixtures,fixed plant/machinery thereon and all rights thereto; the benefit of all contracts and all moneys payable under contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Used vehicle charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to either psa wholesale limited or peugeot motor company PLC under any agreement on any account whatsoever and under this charge
    Brevi particolari
    All rights,title and interest of the dealer in and to the insurances and moneys anmd any return of premiums thereof; all stocks of used vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,formerly known as waters (1896) limited,to the chargee or peugeot motor company PLC under any agreement or this debenture on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WATERS RETAIL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 ott 2011Inizio dell'amministrazione
    04 ott 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Kevin James Coates
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    04 ott 2012Inizio della liquidazione
    05 ott 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Kevin James Coates
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0