ISOFT GROUP (UK) LIMITED

ISOFT GROUP (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISOFT GROUP (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03716736
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KROLL ADVISORY LTD
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ISOFT GROUP LIMITED01 set 201101 set 2011
    ISOFT GROUP PLC19 lug 199919 lug 1999
    PINCO 1179 LIMITED22 feb 199922 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Christopher Neal Halbard come amministratore in data 01 apr 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven James Turpie come amministratore in data 15 lug 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2022

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 15 giu 2022

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 13 dic 2021

    • Capitale: GBP 1.1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 16 set 2021

    • Capitale: GBP 1.1
    3 pagineSH01

    Dettagli del direttore cambiati per Steven James Turpie il 28 apr 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Neal Halbard il 31 mar 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Csc Computer Sciences International Operations Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2020

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrea Fiumicelli come amministratore in data 31 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tina Anne Gough come amministratore in data 07 apr 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher Neal Halbard come amministratore in data 07 apr 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Steven James Turpie come amministratore in data 04 mar 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Maruf Ahmad Majed come amministratore in data 26 feb 2020

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODFINE, Michael Charles
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Segretario
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    British183106810001
    WOODFINE, Michael Charles
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    EnglandBritish208597210001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Segretario
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    British58894020001
    EDELMAN, Howard Todd
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Segretario
    Elizabeth Bay Road
    2011 Elizabeth Bay
    84/108
    Nsw
    Australia
    Australian126124430005
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    British177358270001
    HILL, Teifion Mark
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    Segretario
    59 Hill Top Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HZ Stockport
    Cheshire
    British100105520001
    WHISTON, Timothy Andrew
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    Segretario
    Boothshill Farm
    Booths Lane
    WA13 0PF Lymm
    Cheshire
    British69575560002
    WILSON, Gareth Antony
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    162049470001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Segretario nominato
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ADAMS, Stuart Malcolm
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandAustralian183104980001
    AP GWILYM, Eurfyl, Dr
    12 Ty Draw Road
    CF23 5HA Cardiff
    Amministratore
    12 Ty Draw Road
    CF23 5HA Cardiff
    United KingdomBritish74774890003
    COHEN, Gary Michael
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    Amministratore
    178 Hopetoun Avenue,
    Watsons Bay
    Nsw 2030
    Australia
    AustraliaAustralian125992970001
    CRYNE, Patrick
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    Amministratore
    The Tannery
    Town Lane
    SK14 6HQ Charlesworth
    Cheshire
    EnglandBritish58894020001
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    British63562150001
    DIGBY LORD JONES OF BIRMINGHAM
    58 Elizabeth Court
    NW1 6EJ London
    Amministratore
    58 Elizabeth Court
    NW1 6EJ London
    British88447680001
    FIUMICELLI, Andrea
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalian135619020001
    GOUGH, Tina Anne
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United KingdomBritish229756300001
    GRAHAM, Stephen Paul
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Amministratore
    Brackenridge
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritish97528710001
    GRAY, David William Hart
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224241390001
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    55
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    55
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish51122700007
    HALBARD, Christopher Neal
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    United KingdomBritish152748570001
    HANDLEY, John Martin
    Mintz Cottage
    Cakebole, Chaddesley Corbett
    DY10 4RF Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Mintz Cottage
    Cakebole, Chaddesley Corbett
    DY10 4RF Kidderminster
    Worcestershire
    EnglandBritish75640920001
    HENRY, William Patrick
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Grafton Road
    GL50 2ET Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAmerican119049370001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish44173560008
    KERN, Rene
    36 Butternut Hollow Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Amministratore
    36 Butternut Hollow Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    German89259110001
    KUMAR, Ravi
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    14 Parkham Close
    Daisy Hill Westhaughton
    BL5 2GT Bolton
    Lancashire
    British101025710001
    LEVER, Kenneth
    Beechwood House
    Old Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Beechwood House
    Old Long Grove, Seer Green
    HP9 2QH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British50134030002
    LORIA, Giovanni
    One Pancras Square
    Kings Cross
    N1C 4AG London
    Csc
    United Kingdom
    Amministratore
    One Pancras Square
    Kings Cross
    N1C 4AG London
    Csc
    United Kingdom
    EnglandBritish134764880002
    MACKAY, James Gordon
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft Group Plc
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish178097680001
    MAJED, Maruf Ahmad
    One Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Dxc
    United Kingdom
    Amministratore
    One Pancras Square
    King's Cross
    N1C 4AG London
    Dxc
    United Kingdom
    SingaporeAmerican245085610001
    MOORE, Christopher Edward
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fanthill Hayway Lane
    Hook Norton
    OX15 5QJ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish34428100003
    RICHARDS, Paul
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    Amministratore
    The Barn Green Lane
    South Newington
    OX15 4JH Banbury
    United KingdomBritish126777780001
    SERIES, Ronald Charles
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Daventry Road
    OX16 3JT Banbury
    Isoft
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118534550001
    STEVENS, Adrian Charles
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76964750002
    THOMSON, Andrew James Edward
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Wellesley Road
    GU11 1PZ Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish147270780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wellesley Road
    GU11 1P2 Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    06 ott 2016
    Wellesley Road
    GU11 1P2 Aldershot
    Royal Pavilion
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07073279
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ISOFT GROUP (UK) LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    22 feb 201705 ott 2016La società sa o ha ragione di credere che vi sia una persona registrabile in relazione alla società, ma non l'ha identificata.

    ISOFT GROUP (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    English law governed supplemental security agreement
    Creato il 23 nov 2010
    Consegnato il 30 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all of its rights title and interest in respect of any security account and any amount standing to the credit of any security account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental security agreement
    Creato il 24 mar 2010
    Consegnato il 31 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All estates or interests in the leasehold property, all buildings, erections and fixtures and the benefit of any covenants see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 18 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agreement)
    Transazioni
    • 18 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 30 dic 2009
    Consegnato il 13 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property,all equipment and fixed assets,all shares,all other stocks debentures,bonds,warrants,coupons or other securities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental security agreement
    Creato il 14 feb 2008
    Consegnato il 19 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 300 longbarn boulevard birchwood warrington t/no CH348589. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V., London Branch as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Securityagent)
    Transazioni
    • 19 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security agreement
    Creato il 30 ott 2007
    Consegnato il 14 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V, London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security agreement
    Creato il 30 ott 2007
    Consegnato il 14 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each target guarantor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V, London Branch (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2003
    Creato il 13 apr 2006
    Consegnato il 28 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent company, any chargor or any of the parent company's subsidiaries to the finance parties or any of them and such other banks or financial institutions under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Security Trustee
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest under or arising out of or in respect of supply agreements between the company and its customers. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 30 apr 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 28 apr 2003
    Consegnato il 14 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title benefit and interest, present and future, whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Set-off agreement
    Creato il 30 gen 2003
    Consegnato il 19 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The companies agree that the bank may at any time and from time to time combine or consolidate all or any of the then existing accounts of the companies with all or any of the liabilities of the companies or any of them to the bank under the ancillary facilities and/or set-off and transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 07 nov 2002
    Consegnato il 14 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title benefit and interest present and future under or arising out of or in respect of supply agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hanover Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 14 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 lug 2002
    Consegnato il 20 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money,obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee and to the lenders (or any of them) in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) suite 306,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (ii) suite 202,bridgewater house,58-60 whitworth street,manchester; (iii) units 2.01-2.05 faraday wharf aston science park,holt street,birmingham; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of a life policy
    Creato il 27 mar 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and rights given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortagage of a life policy
    Creato il 27 mar 2000
    Consegnato il 05 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money including bonuses that has accrued or may become payale under the policy. The benefit of all options and righhts given to the company in connection with the policy and all the companys rights and interest in the policy.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 giu 1999
    Consegnato il 24 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ISOFT GROUP (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2022Inizio della liquidazione
    06 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Robert Bines
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0