SERVISTA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSERVISTA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03719982
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SERVISTA LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova SERVISTA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SERVISTA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SERVISTA.COM LIMITED01 feb 200001 feb 2000
    EUTILITIES LIMITED23 giu 199923 giu 1999
    M&R 711 LIMITED25 feb 199925 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di SERVISTA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per SERVISTA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ago 2017

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagine4.72

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2017

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2017

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2016

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2016

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2015

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2015

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2014

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2014

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2013

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2013

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2012

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2012

    7 pagine4.68

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    8 pagine4.40

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:o/c appointuing bruce alexander mackay as liquidator
    7 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risultato della riunione dei creditori

    32 pagine2.23B

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ago 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 feb 2011

    11 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Baker Tilly Restructuruing and 5Th Floor Exhange House 466 Midsummer Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 2EA* in data 21 apr 2010

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di SERVISTA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARMAR, Manoj Kumar
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer160115240001
    ANDRADI, Benedict Pius Marilaan
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChief Executive Officer82360580001
    BERTRAND, Cyril
    12 Rue Tronchet
    Paris
    France 75008
    Amministratore
    12 Rue Tronchet
    Paris
    France 75008
    FrenchFund Manager136535100001
    DU ROY DE BLICQUY, Corentin
    48 Broomhouse Road
    SW6 3QX London
    Amministratore
    48 Broomhouse Road
    SW6 3QX London
    United KingdomBelgianSenior Associate116061580001
    FORD, Howard
    12 Tekels Avenue
    GU15 2LB Camberley
    Surrey
    Amministratore
    12 Tekels Avenue
    GU15 2LB Camberley
    Surrey
    EnglandBritishSenior Vice President22120110001
    GURNANI, Chander Prakash
    Sector 17
    Noida
    A63
    201301
    India
    Amministratore
    Sector 17
    Noida
    A63
    201301
    India
    IndianService133681900001
    MEARING-SMITH, Nicholas Paul
    9 Clonmore Street
    SW18 5EU London
    Amministratore
    9 Clonmore Street
    SW18 5EU London
    EnglandBritishCompany Director103002190002
    PARMAR, Manoj Kumar
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Financial Officer160115240001
    RABINI, Johannes
    Am Volkspark 47
    FOREIGN Berlin
    10715
    Germany
    Amministratore
    Am Volkspark 47
    FOREIGN Berlin
    10715
    Germany
    GermanInvestment Director116353770001
    SOFINNOVA PARTNERS SA
    17 Rue De Surene
    FOREIGN Paris
    75008
    France
    Amministratore
    17 Rue De Surene
    FOREIGN Paris
    75008
    France
    66287570001
    BATES, Alexander John
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    Segretario
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    BritishDirectors23351690002
    GORMAN, John Alfred
    9 Violet Hill
    NW8 9EB London
    Segretario
    9 Violet Hill
    NW8 9EB London
    AmericanCompany Director64683050002
    MOBED, Julie
    9 Brooklands Court
    Brooklands Avenue
    CB2 2BP Cambridge
    Segretario
    9 Brooklands Court
    Brooklands Avenue
    CB2 2BP Cambridge
    British69592510001
    NDUMU, Divine Tamajong, Dr
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    BritishChief Technology Officer106435250001
    OVERTON, Martin John
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    BritishManager92083320001
    SHEETS, Courtney Todd
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    Segretario
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    AmericanDirector64683110002
    SHEETS, Courtney Todd
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    Segretario
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    AmericanCompany Director64683110002
    BATES, Alexander John
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    Amministratore
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    United KingdomBritishDirectors23351690002
    BENNELL, Peter Raymond
    The Old Vicarage
    Church Lane, Playford
    IP6 9DS Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Church Lane, Playford
    IP6 9DS Ipswich
    Suffolk
    BritishGeneral Manager68905300001
    BEST, David Graham
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant34249020002
    BOHANNON, Kyle
    131b Portland Road
    W11 4LW London
    Amministratore
    131b Portland Road
    W11 4LW London
    AmericanPrivate Equity102644730001
    COX, David Michael
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    Amministratore
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    UkBritishCompany Director33300110001
    GARY, Michael Shayne
    3748 Wickcliff Lane
    Memphis
    Tennessee
    38118
    America
    Amministratore
    3748 Wickcliff Lane
    Memphis
    Tennessee
    38118
    America
    AmericanDirector65971100001
    GORMAN, John Alfred
    Servista 32-38 Saffron Hill
    EC1N 8FH London
    Amministratore
    Servista 32-38 Saffron Hill
    EC1N 8FH London
    AmericanCompany Director64683050003
    KARLIN, Mikael
    Uberrheiner Strase 8
    Kirchheim
    D 85551
    Germany
    Amministratore
    Uberrheiner Strase 8
    Kirchheim
    D 85551
    Germany
    SwedishManagement74482400001
    LAFFY, Laurent Pierre Marie Raoul Edmond
    92 Portland Road
    W11 4LN London
    Amministratore
    92 Portland Road
    W11 4LN London
    FrenchVenture Capital61848730001
    LANGSDALE, Philip Richard
    25 Highbury Place
    N5 1QP London
    Amministratore
    25 Highbury Place
    N5 1QP London
    United KingdomBritishDirector32832560002
    LINDOW, Stephan Peter
    Friedrichshaller Strasse 41
    FOREIGN Berlin
    Berlin 14199
    Germany
    Amministratore
    Friedrichshaller Strasse 41
    FOREIGN Berlin
    Berlin 14199
    Germany
    GermanInvestment Director102164480001
    MARSHALL, Brian
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    Amministratore delegato nominato
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    British900008320001
    NDUMU, Divine Tamajong, Dr
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Technology Officer106435250001
    OVERTON, Martin John
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    BritishManager92083320001
    SCHRICKE, Herve
    27 Rue Du Faubourg
    Montmartre
    FOREIGN Paris
    9e (75)
    France
    Amministratore
    27 Rue Du Faubourg
    Montmartre
    FOREIGN Paris
    9e (75)
    France
    FranceFrenchBusiness Man171898440001
    SHEETS, Courtney Todd
    20c Randolph Crescent
    W9 1DR London
    Amministratore
    20c Randolph Crescent
    W9 1DR London
    BritishCompany Director64683110003
    VALKIN, Adam Alexander
    16 Bristol Mews
    W9 2JF London
    Amministratore
    16 Bristol Mews
    W9 2JF London
    United KingdomSouth AfricanNon Executive Director94456980002
    WILLIAMS, Martyn Courtney Bailey
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    Amministratore
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    EnglandBritishDirector37614850003

    SERVISTA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 07 gen 2008
    Consegnato il 15 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Silicon Valley Bank
    Transazioni
    • 15 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    £83,100.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £83,100.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • The Mount Stuart Trust
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    £101,600.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £101,600.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • The Mount Stuart Trust
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 lug 2006
    Consegnato il 11 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Silicon Valley Bank (The Bank)
    Transazioni
    • 11 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 08 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £249,690.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £249,690.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account held by the landlord.
    Persone aventi diritto
    • The Mount Stuart Trust
    Transazioni
    • 08 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £249,690.00 paid and any interest standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Gradecourt Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £138,500.
    Persone aventi diritto
    • Gradecourt Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 13 mag 2000
    Consegnato il 24 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays current account number 50895962. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 20 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and the beneficiaries (as defined) (the "security trustee") or any of them under or in connection with any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All existing and future cash at the bank and in the debts.
    Persone aventi diritto
    • Digital Ventures Ii Limited
    Transazioni
    • 20 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creato il 29 mar 2000
    Consegnato il 30 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £111,190 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit of £111,190 and all losses. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Transworld Land Co. Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SERVISTA LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 feb 2010Fine dell'amministrazione
    03 lug 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Graham Paul Bushby
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Praticante
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Praticante
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    2
    DataTipo
    12 dic 2017Data prevista di scioglimento
    05 feb 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Graham Paul Bushby
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Praticante
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Praticante
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Bruce Alexander Mackay
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0