PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED

PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03720213
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CABOT CONSUMER SERVICES LIMITED 26 ago 199926 ago 1999
    CROCUSBRIGHT LIMITED25 feb 199925 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 set 2017

    15 pagineLIQ03

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    10 pagineLIQ10

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 06 ott 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 set 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Stato del capitale al 20 set 2016

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    4 pagineSH20

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 23 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mag 2016

    Stato del capitale al 25 mag 2016

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    22 pagineAA

    Nomina di Mr Nicholas Gibson Websdell come amministratore in data 20 ago 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Isabel Mary Chadwick come amministratore in data 20 ago 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2015

    Stato del capitale al 08 lug 2015

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Clare Louise Gosling come amministratore in data 15 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Daniel Mundy come amministratore in data 15 giu 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Newton House Cheadle Road Leek Staffordshire ST13 5RG a Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL in data 12 mag 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr David Clive Whitehead come segretario in data 30 mar 2015

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITEHEAD, David Clive
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Segretario
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    196735240001
    CHADWICK, Isabel Mary
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritish174564650002
    MCGIRR, Grahame George Scott
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandScottish184111130001
    MUNDY, Daniel
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish189420920001
    WEBSDELL, Nicholas Gibson
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    EnglandBritish201065000001
    ARCKLESS, Jane Alison
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    British67947660001
    ARNOLD, Katy Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    192244560001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Segretario
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    British5782770001
    HUDSON, Matthew Donald Jeremy
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    Segretario
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    British72420070002
    HYLTON, Rosemarie
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    Segretario
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    British115762060001
    MCKEOWN, Brona Rose
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Segretario
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    193735850001
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Segretario
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    British34173070002
    MOSS, Susan
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Segretario
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    151801210001
    OWEN, Robert James Holland
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    Segretario
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    British73708980005
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLARK, James Roy
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    Amministratore
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    United KingdomAmerican65072010002
    GODDARD, Richard Thomas
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritish63087570001
    GOSLING, Clare Louise
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish204863170001
    GREEN, Peter
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    Amministratore
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    British74913270001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Amministratore
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    British5782770001
    GREGORY, Gerald Arthur
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritish31843730001
    HUGHES, John Richard
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Amministratore
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    EnglandBritish146426540002
    KERNS, Peter William
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    Amministratore
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    United KingdomBritish67171290002
    LEE, Phillip Andrew
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritish89215420001
    MCCARTHY, David James
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    Amministratore
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    EnglandBritish91557750002
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish34173070002
    NEWBY, William Edward
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish140446620001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RICHARDSON, Neville Brian
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish73311810001
    RUSSELL, Andrew Nicholas
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish91395820001
    TWEEDY, David
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British109457050001
    CS SCF MANAGEMENT LIMITED
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    83374930001
    PCSL SERVICES NO.2 LIMITED
    Exchange Tower
    2 Harbour Exchange Square
    E14 9FR London
    Amministratore
    Exchange Tower
    2 Harbour Exchange Square
    E14 9FR London
    66769670003

    PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares (as defined)
    Creato il 29 set 1999
    Consegnato il 15 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility documents (as defined) and this mortgage
    Brevi particolari
    The entire issued ordinary share capital from time to time and all other securities,rights,moneys and property whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgasge Servicing Limited,as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 set 2016Inizio della liquidazione
    29 mar 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0