CAYUGA ESTATES LIMITED

CAYUGA ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAYUGA ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03720598
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAYUGA ESTATES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova CAYUGA ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAYUGA ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HACKREMCO (NO.1462) LIMITED25 feb 199925 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAYUGA ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CAYUGA ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Indirizzo della sede legale modificato da St. Catherines House Oxford Square Oxford Street Newbury Berkshire RG14 1JQ a The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1BP in data 26 apr 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 apr 2017

    LRESEX

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Sally Ann Hayes come segretario in data 15 apr 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2016

    Stato del capitale al 24 mar 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Malcolm Vincent Morris come amministratore in data 30 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Francis Megan come amministratore in data 30 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2015

    Stato del capitale al 26 mar 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mar 2014

    Stato del capitale al 13 mar 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Nomina di Mr Michael Francis Megan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Gubb come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Hugo Edward Stainton Jackson il 25 feb 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CAYUGA ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Hugo Edward Stainton
    The Coach House
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Coach House
    Marston Hill
    GL7 5LF Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritishInvestment Manager146529390001
    MCFARLANE, Andrew James
    Hilarion
    Yew Tree Way Prestbury
    SK10 4EX Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Hilarion
    Yew Tree Way Prestbury
    SK10 4EX Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor39119700005
    MORRIS, Malcolm Vincent
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    The Pinnacle
    Amministratore
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    The Pinnacle
    United KingdomBritishAccountant142632870001
    PORTER, Barry
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Dove Park
    WD3 5NY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHead Real Estate Management99637030001
    HAYES, Sally Ann
    Dormer Close
    RG14 6NL Newbury
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Dormer Close
    RG14 6NL Newbury
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary133119060005
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    GUBB, Peter Griffiths
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish Chartered Surveyor6163460002
    KIDD, Timothy Guy
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    Amministratore
    52 Orbel Street
    SW11 3NZ London
    BritishChartered Surveyor9401710001
    LEE, Wilson Yao Chang
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    Amministratore
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    AmericanInvestment Banker52557130001
    MEGAN, Michael Francis
    Oxford Square
    Oxford Street
    RG14 1JQ Newbury
    St. Catherines House
    Berkshire
    Amministratore
    Oxford Square
    Oxford Street
    RG14 1JQ Newbury
    St. Catherines House
    Berkshire
    EnglandIrishAccountant46067860003
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Amministratore delegato nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    CAYUGA ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Subordination deed created by the company (formerly known as hackremco (no.1462) limited
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 20 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future liabilities and obligations due or to become due from the company (as "borrower") to the chargee (the "lender") arising under or in connection with the senior credit agreement and the other finance documents (as defined) (the "senior liabilities")
    Brevi particolari
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1 3.2, or 5.2 of the subordination deed the company shall save for permitted payments hold the amount received on trust for the lender.
    Persone aventi diritto
    • Depfa Bank Ag
    Transazioni
    • 20 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Subordination deed
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 19 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future sums liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee (the "lender") arising under or in connection with the junior credit agreement (as defined) and the other finance documents (as defined) (the "junior liabilities")
    Brevi particolari
    If any amount of subordinated liabilities is discharged by payment repayment prepayment set-off or in any other manner in contravention of clauses 2.1.1. 3.2, or 5.2 of the subordination deed the company shall save for permitted payments hold the amount received on trust for the lender. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transazioni
    • 19 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 20 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any other party to a finance document to the chargee under the terms of the finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Depfa Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 20 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 lug 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Security deed
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 19 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies liabilities and present and future obligations whether as principal or surety whether certain or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each of the obligors or any other party to a finance document to the chargee under the finance documents including any legal and other costs charges and expenses incurred by the chargee in relation to the security deed or in enforcing protecting or realising the security hereby created on a full unqualified indemnity basis
    Brevi particolari
    Properties k/a freehold property at 45 high street barnstaple t/n DN306055, 35 winchester street basingstoke t/n HP566481, 24/32 high street bromley t/n K126833 for further properties charged please see schedule attatched to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mable Commercial Funding Limited
    Transazioni
    • 19 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAYUGA ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 apr 2018Data di scioglimento
    05 apr 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas John Edwards
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praticante
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Graham Paul Bushby
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Praticante
    Rsm Restructuring Advisory Llp The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0