ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED

ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03721267
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O MERCER & HOLE
    Fleet Place House 2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRC LIMITED02 lug 199902 lug 1999
    DE FACTO 761 LIMITED25 feb 199925 feb 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da , Stadco Queensway, Hortonwood, Telford, Shropshire, TF1 7LL, United Kingdom in data 25 feb 2014

    2 pagineAD01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 7

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 037212670011

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 3

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 10

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 037212670012

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 9

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 5

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 4

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 6

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 8

    5 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 037212670012, creata il 29 ago 2013

    82 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 037212670011, creata il 29 ago 2013

    74 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    6 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Kelvin Brian Morgan come amministratore in data 11 giu 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mag 2013

    Stato del capitale al 30 mag 2013

    • Capitale: GBP 949,907
    SH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 8

    5 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYHURST, Michael
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Fleet Place House
    Segretario
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Fleet Place House
    BritishChartered Accountant15201970002
    MACLEOD, Gregory Ian
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Fleet Place House
    Amministratore
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Fleet Place House
    United KingdomAustralianCompany Director60518160005
    CRIBB, Nicholas Stephen
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    British100811140001
    DAVIES, John Graeme
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary72253030004
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Segretario
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishCompany Director1600540001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary36008490001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector72559760001
    HATTON, Gary John
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishDirector136056160001
    HISLOP, Robert
    2 Baxters Brae
    Kirkmuirhill
    ML11 9SU Lanark
    Lanarkshire
    Amministratore
    2 Baxters Brae
    Kirkmuirhill
    ML11 9SU Lanark
    Lanarkshire
    BritishDirector20518950001
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    BritishDirector131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector10529040001
    LEEFE, Simon Neville Arden
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    Amministratore
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    United KingdomBritishVenture Capitalist136410560001
    LENG, David Brian
    Main Street
    Youlgrave
    DE45 1UW Bakewell
    Hardanger
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Main Street
    Youlgrave
    DE45 1UW Bakewell
    Hardanger
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131792690001
    LONGBOTTOM, Stephen
    Church Farm
    Towngate
    HD6 4HP Clifton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Church Farm
    Towngate
    HD6 4HP Clifton
    West Yorkshire
    BritishCompany Director106802900001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Queensway
    Hortonwood
    TF1 7LL Telford
    Stadco
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Queensway
    Hortonwood
    TF1 7LL Telford
    Stadco
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Amministratore
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector40953790002
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director1600540001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary36008490001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2013
    Consegnato il 06 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transazioni
    • 06 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 29 ago 2013
    Consegnato il 04 set 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Deed of assignment of deferred consideration
    Creato il 20 nov 2009
    Consegnato il 25 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    £500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in the deferred consideration.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 2006
    Consegnato il 07 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its present and future right, title and interest in and to the property, unit 1 calver quay, calver road, warrington, cheshire t/no CH534698. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transazioni
    • 07 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 14 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit b belbins business park cupernham lane romsey t/no HP569128 all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery all easements all proceeds of sale the benefit of all covenants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 2005
    Consegnato il 14 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 11 mulberry business park fishponds road wokingham t/no BK276518 all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery all easements all proceeds of sale the benefit of all covenants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 08 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the north side of byron avenue lowmoor industrial estate kirkby-in-ashfield mansfield. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 01 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the north west side of whaley road south yorkshire industrial estate barugh barnsley south yorkshire t/nos SYK87365 and SYK8728, land and buildings lying to the north of dodsworth street darlington t/no DU193819 and former sutton-in-ashfield central station and goods yard 79-81 station road sutton-in-ashfield mansfield nottinghamshire t/no NT150946 all buildings erections fittings and fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 01 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 24 november 2005 and
    Creato il 18 nov 2005
    Consegnato il 30 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Newhouse industrial estate newhouse motherwell t/no LAN71750.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 2 aston fields ind. Estate carver road stafford t/no SF349786. Block 14 newhouse ind. Est. Newhouse motherwell t/no LAN71750. Whitehead docks, maesglas, newport t/no WA302230. (For further property refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 14 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all moneys, obligations and liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company to chase manhattan international limited as agent (the "agent"), chase manhattan PLC as arranger (the "arranger"), the banks or financial institutions set out in schedule 1 of the facilities agreement (as defined) or which assume rights and obligations pursuant to a substitution certificate (the "banks"), the chase manhattan bank and the governor and company of the bank of scotland ("bos") and such other banks and financial institutions as agreed by the company and the agent (the "ancillary facilities banks"), the chase manhattan bank (the "acquisition hedge counterparty"), bos and such other banks and financial institutions which shall at any relevant time be party to any hedge transactions (the "hedge counterparties") and the security agent (the "finance parties")(or any of them, in each case including their respective successors in title, assignees and transferees) including, without limitation, all monies, obligations and liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the finance documents (as defined), the guarantees and indemnities given by the company under the debenture and all other provisions of the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 14 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ACERTEC CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    23 mag 2015Data di scioglimento
    14 feb 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Laughton
    Fleet Place House 2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Praticante
    Fleet Place House 2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Peter John Godfrey-Evans
    Mercer & Hole Fleet Place House
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London
    Praticante
    Mercer & Hole Fleet Place House
    2 Fleet Place
    EC4M 7RF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0