E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED

E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàE.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03722631
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    • (1120) /

    Dove si trova E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hil House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CALEDONIA ENERGY LIMITED07 nov 200307 nov 2003
    CONSORT RESOURCES LIMITED14 mag 199914 mag 1999
    BURGINHALL 1094 LIMITED01 mar 199901 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:- re. Books
    1 pagineLIQ MISC RES

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 giu 2009

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagine4.70

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    16 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUSS, Judith
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    Amministratore
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    German126797980001
    COLE, Martin
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    Amministratore
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    British59419030002
    ASHMORE, Richard John
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    Segretario
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    British84884080001
    BATE, Christopher Malcolm
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    Segretario
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    British77942170001
    GROOM, Malcolm David John
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    British29602720001
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    GRAYS INN SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    81652080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Segretario
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BELL, Andrew Stewart
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    Amministratore
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    United KingdomBritish95066820001
    BENKE, Eike, Dr
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    Amministratore
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    German32474820002
    BLAKEY, Peter
    Halstead Chestnut Walk
    B95 5JN Henley-In-Arden
    West Midlands
    Amministratore
    Halstead Chestnut Walk
    B95 5JN Henley-In-Arden
    West Midlands
    British3754730001
    CARVER, Lesley Jean
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Amministratore
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    British54021290001
    CARVER, Lesley Jean
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Amministratore
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    British54021290001
    EARL, Peter Richard Stephen
    Shipton Lodge
    OX7 6DG Shipton-Under-Wychwood
    Oxfordshire
    Amministratore
    Shipton Lodge
    OX7 6DG Shipton-Under-Wychwood
    Oxfordshire
    United KingdomBritish7799770001
    EDGLEY, Steven Neville
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85718530001
    FERGUSON, Donald
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    Amministratore
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    British88767730001
    GROOM, Malcolm David John
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29602720001
    HAMMOND, Philip
    Send Barns
    Send Barns Lane, Send
    GU23 7BT Ripley
    Amministratore
    Send Barns
    Send Barns Lane, Send
    GU23 7BT Ripley
    EnglandBritish287139780001
    HAWKINS, Warren
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    Amministratore
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    American94520330001
    HOGAN, John Anthony
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish94257040001
    HONEYBOURNE, John William Gervase
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    Amministratore
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    UsaBritish94265940001
    HUNTER, Alexander
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    Amministratore
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    British73259250003
    LEGG, Jonathan Victor Lewis
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    Amministratore
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    United KingdomBritish67082340002
    MACAULAY, William E.
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    Amministratore
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    United StatesAmerican238080500001
    MACDONALD, Jeffrey Saunders
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    Amministratore
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    British87467740001
    MARIS, Antony Wayne
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    Amministratore
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    EnglandBritish78957850001
    MOYNIHAN, Colin Berkeley, Lord
    Regency Cottage
    The Esplanade, Sandgate
    CT20 3DP Folkestone
    Kent
    Amministratore
    Regency Cottage
    The Esplanade, Sandgate
    CT20 3DP Folkestone
    Kent
    British78913240003
    MURCHISON, John Hardy
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    Amministratore
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    American88904040001
    PRIEN, Nicolo
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    Amministratore
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    German108803940001
    PRINGLE, Keith James
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    UkUk61942150003
    REICHETSEDER, Peter, Prof Dr
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Amministratore
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Austrian93247640002
    ROTHERMUND, Heinz Charles
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Amministratore
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Swiss122144690001
    SHAW, Sandra Nan Demby
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    Amministratore
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    EnglandBritish78957930001
    SIVERTSEN, Frank Allan
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Amministratore
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Norwegian109251340002
    TAYLOR, Peter
    10 Blackheath Park
    SE3 9RP London
    Amministratore
    10 Blackheath Park
    SE3 9RP London
    EnglandBritish3754740001

    E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second-ranking borrowing base asset security agreement
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 23 ott 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as consort resources limited to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of an equitable mortgage all shares in any member of the group, by way of a floating charge its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities owned by it or held by any nominee on its behalf.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Trustee Fore Itself and the Secured Creditors
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2001
    Consegnato il 13 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Brevi particolari
    Fixed charge all of the assigned assets, all group shares and related rights accruing to the group shares. Floating charge all its undertaking and assets (all terms defined therein).
    Persone aventi diritto
    • Txu Europe Group PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 feb 2001
    Consegnato il 16 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dynergy Marketing and Trading Sarl
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 07 feb 2001
    Consegnato il 15 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party (and for the avoidance of doubt the term finance document includes all amendments and supplements including supplements providing for further advances)
    Brevi particolari
    1) assignment all of the assigned assets except in the case of any rights under any project documents. 2) the fixed charge over all of the assigned assets to the extent (if any) not effectively assigned under clause 2.1 (assignment) of the security agreement. All group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares; and all property specified in schedule 1 to the security agreement. 3) floating charge all its undertaking and assets both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 15 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination agreement
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 11 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future liabilities of the obligor to each finance party, under or in connection with, or on rescission of, the finance documents (the "senior debt")
    Brevi particolari
    The subordination agreement provides that if the chargor receives a payment or distribution in respect of any of the junior debt (other than a permitted payment) from the obligor or any other source. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 11 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    The share charge provides that the chargor as security for the payment of all the secured liabilities and with full title gurantee charges in favour of the agent by way of a first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 apr 2000
    Consegnato il 19 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £294,925 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Rent deposit £294,925. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Development Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2010Data di scioglimento
    09 giu 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Richard Frederick Day
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Praticante
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0