MINDLEADERS UK LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMINDLEADERS UK LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03723561
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MINDLEADERS UK LTD?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MINDLEADERS UK LTD?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MINDLEADERS UK LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THIRDFORCE CLM LTD25 ott 200625 ott 2006
    CREATIVE LEARNING MEDIA LIMITED 10 apr 200110 apr 2001
    THE CREATIVE MEDIA GROUP LIMITED23 ott 200023 ott 2000
    CREATIVE MARKETING MEDIA LIMITED01 mar 199901 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di MINDLEADERS UK LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MINDLEADERS UK LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2017

    10 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Compass House 2nd Floor 207-215 London Road Camberley GU15 3EY a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 09 nov 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 ott 2016

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 apr 2016

    Stato del capitale al 06 apr 2016

    • Capitale: GBP 1,214.39
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Anthony Philip Glass come amministratore in data 20 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Thomas Young come amministratore in data 20 gen 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 gen 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mar 2015

    Stato del capitale al 19 mar 2015

    • Capitale: GBP 1,214.39
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2014

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Intertrust Holdings (Uk) Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Intertrust (Uk) Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Dettagli del segretario cambiati per Intertrust (Uk) Limited il 13 mag 2014

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2014

    Stato del capitale al 02 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,214.39
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2013

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 36 Windsor Street Uxbridge Middlesex UB8 1AB* in data 12 feb 2013

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 gen 2013

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Anthony Paul Amato come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Kevin Thomas Young come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MINDLEADERS UK LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Segretario
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06307550
    188126550001
    AMATO, Anthony Paul
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    United Kingdom
    U S AAmerican91299200001
    GLASS, Antony Philip
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    United KingdomBritish205157650003
    ARAUJO, Sonia Maria Machado, Dr
    Highfield
    Hambridge
    TA10 0BP Langport
    Somerset
    Segretario
    Highfield
    Hambridge
    TA10 0BP Langport
    Somerset
    Portuguese63068500005
    PARSONS, Edward Malcolm
    71 Church Lane
    Backwell
    BS48 3JL Bristol
    Segretario
    71 Church Lane
    Backwell
    BS48 3JL Bristol
    British39065870002
    INTERTRUST HOLDINGS (UK) LIMITED
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    Segretario
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06263011
    126631680006
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Segretario nominato
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    ARAUJO, Sonia Maria Machado, Dr
    Highfield
    Hambridge
    TA10 0BP Langport
    Somerset
    Amministratore
    Highfield
    Hambridge
    TA10 0BP Langport
    Somerset
    Portuguese63068500005
    CURNOCK COOK, Mary
    9 Shaa Road
    W7 3LN London
    Amministratore
    9 Shaa Road
    W7 3LN London
    British91471260001
    FEAR, Paul Daniel
    Higher Barn
    Pound Lane East Lydeard
    TA4 3DN Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Higher Barn
    Pound Lane East Lydeard
    TA4 3DN Taunton
    Somerset
    EnglandBritish7800970003
    MAGUIRE, Alan Thomas
    Milltown Avenue
    Mount St Annes
    6 Milltown
    32
    Dublin
    Amministratore
    Milltown Avenue
    Mount St Annes
    6 Milltown
    32
    Dublin
    IrelandIrish196789170001
    MATTHEWS, Charles Lewis
    Old Red Lion
    Millers Lane Hornton
    OX15 6BS Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Red Lion
    Millers Lane Hornton
    OX15 6BS Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish162976900001
    MCGOVERN, Eimer
    10 Richmond
    Newtown Park Avenue
    IRISH Blackrock
    Dublin
    Ireland
    Amministratore
    10 Richmond
    Newtown Park Avenue
    IRISH Blackrock
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish79762340001
    O'SULLIVAN, Brendan
    231 Templeogue Road
    Templeogue
    Dublin 6w
    Ireland
    Amministratore
    231 Templeogue Road
    Templeogue
    Dublin 6w
    Ireland
    IrelandIrish109527420001
    PARKES, Jonathan
    The Boulders
    Sydenham Road
    IRISH Dundrum
    Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    The Boulders
    Sydenham Road
    IRISH Dundrum
    Dublin 14
    Ireland
    Irish109527350001
    SAUNDERS, Colm
    36 Windsor Street
    Uxbridge
    UB8 1AB Middlesex
    Amministratore
    36 Windsor Street
    Uxbridge
    UB8 1AB Middlesex
    IrelandIrish154296510001
    TAYLOR, Richard Francis
    Creative Learning Media
    Bowdens Business Centre
    TA10 0BP Somerset
    Amministratore
    Creative Learning Media
    Bowdens Business Centre
    TA10 0BP Somerset
    British103753460001
    YOUNG, Kevin Thomas
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandIrish86833660001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Amministratore delegato nominato
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    MINDLEADERS UK LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Lease
    Creato il 16 mag 2006
    Consegnato il 02 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £950.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rent deposit sum of £950.00.
    Persone aventi diritto
    • Henry Charles Lang and Richard John Lang
    Transazioni
    • 02 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Lease
    Creato il 16 mag 2006
    Consegnato il 02 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,862.50 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rent deposit sum of £2,862.50.
    Persone aventi diritto
    • Bowdens Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 02 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge over stock
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge all stock of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 05 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MINDLEADERS UK LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 ott 2016Inizio della liquidazione
    30 nov 2017Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0