MINDLEADERS UK LTD
Panoramica
| Nome della società | MINDLEADERS UK LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03723561 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MINDLEADERS UK LTD?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova MINDLEADERS UK LTD?
| Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MINDLEADERS UK LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THIRDFORCE CLM LTD | 25 ott 2006 | 25 ott 2006 |
| CREATIVE LEARNING MEDIA LIMITED | 10 apr 2001 | 10 apr 2001 |
| THE CREATIVE MEDIA GROUP LIMITED | 23 ott 2000 | 23 ott 2000 |
| CREATIVE MARKETING MEDIA LIMITED | 01 mar 1999 | 01 mar 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MINDLEADERS UK LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per MINDLEADERS UK LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2017 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Compass House 2nd Floor 207-215 London Road Camberley GU15 3EY a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 09 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony Philip Glass come amministratore in data 20 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Thomas Young come amministratore in data 20 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Intertrust Holdings (Uk) Limited come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Intertrust (Uk) Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Intertrust (Uk) Limited il 13 mag 2014 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2013 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 36 Windsor Street Uxbridge Middlesex UB8 1AB* in data 12 feb 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 gen 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony Paul Amato come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Thomas Young come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MINDLEADERS UK LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Segretario | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| AMATO, Anthony Paul | Amministratore | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 United Kingdom United Kingdom | U S A | American | 91299200001 | |||||||||
| GLASS, Antony Philip | Amministratore | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom | United Kingdom | British | 205157650003 | |||||||||
| ARAUJO, Sonia Maria Machado, Dr | Segretario | Highfield Hambridge TA10 0BP Langport Somerset | Portuguese | 63068500005 | ||||||||||
| PARSONS, Edward Malcolm | Segretario | 71 Church Lane Backwell BS48 3JL Bristol | British | 39065870002 | ||||||||||
| INTERTRUST HOLDINGS (UK) LIMITED | Segretario | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 England |
| 126631680006 | ||||||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Segretario nominato | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||||||
| ARAUJO, Sonia Maria Machado, Dr | Amministratore | Highfield Hambridge TA10 0BP Langport Somerset | Portuguese | 63068500005 | ||||||||||
| CURNOCK COOK, Mary | Amministratore | 9 Shaa Road W7 3LN London | British | 91471260001 | ||||||||||
| FEAR, Paul Daniel | Amministratore | Higher Barn Pound Lane East Lydeard TA4 3DN Taunton Somerset | England | British | 7800970003 | |||||||||
| MAGUIRE, Alan Thomas | Amministratore | Milltown Avenue Mount St Annes 6 Milltown 32 Dublin | Ireland | Irish | 196789170001 | |||||||||
| MATTHEWS, Charles Lewis | Amministratore | Old Red Lion Millers Lane Hornton OX15 6BS Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 162976900001 | |||||||||
| MCGOVERN, Eimer | Amministratore | 10 Richmond Newtown Park Avenue IRISH Blackrock Dublin Ireland | Ireland | Irish | 79762340001 | |||||||||
| O'SULLIVAN, Brendan | Amministratore | 231 Templeogue Road Templeogue Dublin 6w Ireland | Ireland | Irish | 109527420001 | |||||||||
| PARKES, Jonathan | Amministratore | The Boulders Sydenham Road IRISH Dundrum Dublin 14 Ireland | Irish | 109527350001 | ||||||||||
| SAUNDERS, Colm | Amministratore | 36 Windsor Street Uxbridge UB8 1AB Middlesex | Ireland | Irish | 154296510001 | |||||||||
| TAYLOR, Richard Francis | Amministratore | Creative Learning Media Bowdens Business Centre TA10 0BP Somerset | British | 103753460001 | ||||||||||
| YOUNG, Kevin Thomas | Amministratore | Old Jewry 7th Floor EC2R 8DU London 11 United Kingdom United Kingdom | England | Irish | 86833660001 | |||||||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
MINDLEADERS UK LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Lease | Creato il 16 mag 2006 Consegnato il 02 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £950.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Rent deposit sum of £950.00. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Lease | Creato il 16 mag 2006 Consegnato il 02 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,862.50 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Rent deposit sum of £2,862.50. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 lug 2005 Consegnato il 02 ago 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge over stock | Creato il 01 ott 2004 Consegnato il 05 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Floating charge all stock of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 ott 2004 Consegnato il 05 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge over book debts | Creato il 01 ott 2004 Consegnato il 05 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MINDLEADERS UK LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0