NPI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNPI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03725037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NPI LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NPI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1020 Eskdale Road
    RG41 5TS Winnersh
    Wokingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NPI LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    941ST SHELF TRADING COMPANY LIMITED03 mar 199903 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di NPI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per NPI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6WG a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS in data 16 mag 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 apr 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Moss il 18 apr 2018

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Rizwan Sheriff come amministratore in data 30 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Shamira Mohammed come amministratore in data 30 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Moss il 12 lug 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Moss il 12 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 250,000,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Moss il 13 lug 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 250,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Merrick come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Shamira Mohammed come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2014

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 250,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di NPI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Segretario
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3588041
    146249030001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish151524430063
    SHERIFF, Rizwan
    Wythall Green Way
    Wythall Green
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall Green
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    England
    EnglandBritish238986770001
    O'BRIEN, Steven John
    10 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    10 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    British9964050001
    WATSON, Gerald Alistair
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    Segretario
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    British47729060001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    BATCHELOR, Paul John
    Flat H
    9 Eaton Square
    SW1W 9DB London
    Amministratore
    Flat H
    9 Eaton Square
    SW1W 9DB London
    Australian64778980003
    BATES, Malcolm Rowland, Sir
    Mulberry Close
    Croft Road
    RG8 9ES Goring-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mulberry Close
    Croft Road
    RG8 9ES Goring-On-Thames
    Oxfordshire
    British13829970002
    CORMACK, Ian Donald
    24 Kensington Court Gardens
    Kensington Court Place
    W8 5QF London
    Amministratore
    24 Kensington Court Gardens
    Kensington Court Place
    W8 5QF London
    EnglandBritish114870300001
    COSTAIN, Peter John
    Heronden Smallhythe Road
    TN30 7LN Tenterden
    Kent
    Amministratore
    Heronden Smallhythe Road
    TN30 7LN Tenterden
    Kent
    EnglandBritish45321580001
    CROSS BROWN, Tom
    Shipton Old Farm
    MK18 3JL Winslow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Shipton Old Farm
    MK18 3JL Winslow
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglish154509390001
    CUSINS, John Robert
    High Gables
    Holly Lane
    AL5 5DY Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    High Gables
    Holly Lane
    AL5 5DY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish107782060002
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Amministratore
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    DAVIDSON, Anthony Beverley
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish61933730002
    DRABBLE, John Alexander
    7 Altenburg Gardens
    Battersea
    SW11 1JH London
    Amministratore
    7 Altenburg Gardens
    Battersea
    SW11 1JH London
    British Australian88349990002
    DUNN, Craig William
    52 Douglas Street
    2076 St Ives
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    52 Douglas Street
    2076 St Ives
    New South Wales
    Australia
    AustraliaBritish198499280001
    EDMANS, Laurence Michael
    Allens Oast
    Old Road
    TN12 5ER East Peckham
    Kent
    Amministratore
    Allens Oast
    Old Road
    TN12 5ER East Peckham
    Kent
    EnglandBritish145578560001
    EVANS, Jonathan Peter
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish70566830001
    EVANS, Jonathan Peter
    The Red House 122 Heol Isaf
    Radyr
    CF15 8EA Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    The Red House 122 Heol Isaf
    Radyr
    CF15 8EA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish70566830001
    FERGUSON, Duncan George Robin
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish144264940001
    FRASER, Thomas Aird
    40 Elmbourne Road
    Tooting
    SW17 8JR London
    Amministratore
    40 Elmbourne Road
    Tooting
    SW17 8JR London
    United KingdomAustralian74112910001
    GORMAN, William Richard
    25 Towerside
    150 Wapping High Street
    E1W 3PH Wapping
    London
    Amministratore
    25 Towerside
    150 Wapping High Street
    E1W 3PH Wapping
    London
    Australian59757440001
    GUPTA, Ashok Kumar
    26 Parsons Green
    SW6 4UH London
    Amministratore
    26 Parsons Green
    SW6 4UH London
    EnglandBritish68708650004
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    10 Hillgate Street
    W8 7SR London
    Amministratore
    10 Hillgate Street
    W8 7SR London
    United KingdomBritish93239900003
    HOTSON, Anthony Charles
    Church Street
    Wadenhoe
    PE8 5ST Peterborough
    Aubrey House
    Cambridgeshire
    Uk
    Amministratore
    Church Street
    Wadenhoe
    PE8 5ST Peterborough
    Aubrey House
    Cambridgeshire
    Uk
    British30112390003
    HUNTLEY, David Charles
    Burwood Park Road
    Hersham
    KT12 5LJ Walton On Thames
    7
    Surrey
    Amministratore
    Burwood Park Road
    Hersham
    KT12 5LJ Walton On Thames
    7
    Surrey
    United KingdomBritish133958530001
    LAUGHLIN, Ian William
    32 Melvinshaw
    KT22 8SX Leatherhead
    Amministratore
    32 Melvinshaw
    KT22 8SX Leatherhead
    Australian86985820003
    LEVER, Colin David
    38 Oakleigh Park South
    N20 9JN London
    Amministratore
    38 Oakleigh Park South
    N20 9JN London
    British14678320001
    LUSCOMBE, Kerr
    Melbourne Court, Braidpark Drive
    Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    3e
    United Kingdom
    Amministratore
    Melbourne Court, Braidpark Drive
    Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    3e
    United Kingdom
    ScotlandBritish83541890001
    LYONS, Alastair David
    Tolhurst Barn
    Birchetts Green Lane
    TN5 7LJ Ticehurst
    East Sussex
    Amministratore
    Tolhurst Barn
    Birchetts Green Lane
    TN5 7LJ Ticehurst
    East Sussex
    British75697200001
    MAIDENS, Ian Graham
    TN5
    Amministratore
    TN5
    United KingdomBritish103576480002
    MCGLASHAM, Christopher
    7 Shepperton Close
    Great Billing
    NN3 9NT Northampton
    Amministratore
    7 Shepperton Close
    Great Billing
    NN3 9NT Northampton
    EnglandBritish45546750001
    MEEHAN, Brendan Joseph
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98270380001
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish74114060001
    MOHAMMED, Shamira
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Amministratore
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish253534040001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NPI LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1016269
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NPI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 14 gen 2008
    Consegnato il 17 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest in or in respect of the property meaning cash and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Opal Reassurance Limited
    Transazioni
    • 17 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest in respect of the property being cash and securities all other property and all rights cash and the collateral accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Opal Reassurance Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 set 1999
    Consegnato il 09 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all money and liabilities due or to become due from the company to the purchaser under the reversion sale programme agreement and under the debenture and all money and liabilities due or to become due from the company to the security trustee under the mortality policy agreement in whatsoever manner
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all monies from time to time standing to the credit of the specific house price account. By way of first floating charge the charged property to the extent not effectively charged by way of first fixed charge or assigned by way of security.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC(As Security Trustee for the Purchaser)
    Transazioni
    • 09 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    NPI LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 apr 2018Inizio della liquidazione
    08 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0